CLIP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLIP LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00933144
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CLIP LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CLIP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Clip Ltd Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLIP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RUNACRES F0WLER EXHIBITS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    P & L DECOR LIMITED31 mag 196831 mag 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLIP LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CLIP LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al12 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma26 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al12 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per CLIP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Michael Povey come segretario in data 30 apr 2024

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Pamela Tracy Lea come segretario in data 30 apr 2024

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Pamela Tracey Lea come amministratore in data 30 apr 2024

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Dorinda Anne Runacres il 30 apr 2024

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2023

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Runacres come amministratore in data 08 nov 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Pamela Tracey Lea come amministratore in data 08 nov 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2020 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Geoffrey David Barrett come segretario in data 25 apr 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Pamela Tracy Lea come segretario in data 25 apr 2019

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mrs Dorinda Anne Runacres come persona con controllo significativo il 01 gen 2018

    2 paginePSC04

    Chi sono gli amministratori di CLIP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    POVEY, Michael
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    Segretario
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    322861310001
    BARRETT, Geoffrey David
    1 Hesding Close
    BS15 3LP Bristol
    South Gloucestershire
    Amministratore
    1 Hesding Close
    BS15 3LP Bristol
    South Gloucestershire
    EnglandBritishManaging Director84135910001
    RUNACRES, Dorinda Anne
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    England
    Amministratore
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    England
    United KingdomBritishDirector156212540002
    RUNACRES, Paul
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    Amministratore
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    EnglandBritishDirector291461760001
    BARRETT, Geoffrey David
    1 Hesding Close
    BS15 3LP Bristol
    South Gloucestershire
    Segretario
    1 Hesding Close
    BS15 3LP Bristol
    South Gloucestershire
    British84135910001
    DIXON, Andy
    2 Head Croft
    Flax Bourton
    BS48 1US Bristol
    Avon
    Segretario
    2 Head Croft
    Flax Bourton
    BS48 1US Bristol
    Avon
    BritishFinancial Manager119160270001
    FOWLER, Alan
    Tretheague Mill
    TR3 7AF Stithians
    Cornwall
    Segretario
    Tretheague Mill
    TR3 7AF Stithians
    Cornwall
    British39258840001
    LEA, Pamela Tracy
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    Segretario
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    257875460001
    LONGHORN, Mark
    12 Branscombe Road
    BS9 1SN Bristol
    Avon
    Segretario
    12 Branscombe Road
    BS9 1SN Bristol
    Avon
    BritishFinance Director101263860001
    OATLEY, Philip
    The Chantry Lacock Road
    SN13 9HS Corsham
    Wiltshire
    Segretario
    The Chantry Lacock Road
    SN13 9HS Corsham
    Wiltshire
    British48310200001
    PILLINGER, Christopher Richard
    35 Martock Road
    Keynsham
    BS18 1XA Bristol
    Avon
    Segretario
    35 Martock Road
    Keynsham
    BS18 1XA Bristol
    Avon
    British12851230001
    COTTRILL, Timothy Mark
    1 Masons Way
    SN13 9XW Corsham
    Wiltshire
    Amministratore
    1 Masons Way
    SN13 9XW Corsham
    Wiltshire
    BritishExport Sales Director41671420001
    FOWLER, Alan
    Halzephron House
    Gunwalloe
    TR12 7QD Helston
    Cornwall
    Amministratore
    Halzephron House
    Gunwalloe
    TR12 7QD Helston
    Cornwall
    BritishChartered Accountant39258840002
    HEDGES, Geoffrey James
    West Hay
    Tockenham
    SN4 7PH Wootton Bassett
    Swindon
    Amministratore
    West Hay
    Tockenham
    SN4 7PH Wootton Bassett
    Swindon
    EnglandBritishCompany Director21015900001
    HIGGINS, Gordon Thomas
    43 The Pastures
    Westwood
    BA15 2BH Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    43 The Pastures
    Westwood
    BA15 2BH Bradford On Avon
    Wiltshire
    United KingdomBritishProduction Director120537910001
    KING, David Frank
    Cobden House Hazelbury Hill
    Box
    SN13 8LB Corsham
    Wiltshire
    Amministratore
    Cobden House Hazelbury Hill
    Box
    SN13 8LB Corsham
    Wiltshire
    BritishEngineer12851250001
    LEA, Pamela Tracey
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    Amministratore
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    EnglandBritishDirector291461560001
    LONGHORN, Mark
    12 Branscombe Road
    BS9 1SN Bristol
    Avon
    Amministratore
    12 Branscombe Road
    BS9 1SN Bristol
    Avon
    EnglandBritishFinance Director101263860001
    MARTIN, Christopher Scott
    Little Cherkenhill
    Leigh Sinton
    WR13 5DE Worcestershire
    Amministratore
    Little Cherkenhill
    Leigh Sinton
    WR13 5DE Worcestershire
    BritishSales And Marketing Director40491560002
    OATLEY, Philip
    The Chantry Lacock Road
    SN13 9HS Corsham
    Wiltshire
    Amministratore
    The Chantry Lacock Road
    SN13 9HS Corsham
    Wiltshire
    EnglandBritishFinancial Controller48310200001
    ROWE, Robin Arthur
    13 Somerset View
    CF32 0PP Ogmore By Sea
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    13 Somerset View
    CF32 0PP Ogmore By Sea
    Vale Of Glamorgan
    BritishOperations Director78042950001
    RUNACRES, Arthur John Frederick
    The Old Laundry
    Grittleton
    SN14 6AP Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    The Old Laundry
    Grittleton
    SN14 6AP Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritishMarketeer12851260001
    STANBRIDGE, Elizabeth Jane
    The Cottage
    St Johns Street, Hawkesbury
    GL9 1BB Upton
    South Gloucestershire
    Amministratore
    The Cottage
    St Johns Street, Hawkesbury
    GL9 1BB Upton
    South Gloucestershire
    United KingdomBritishMarketeer95896850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLIP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Dorinda Anne Runacres
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    01 gen 2018
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Geoffrey David Barrett
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    06 apr 2016
    Church Road
    Wick
    BS30 5RD Bristol
    Clip Ltd
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CLIP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 03 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    210 bristol business park coldharbour road bristol. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 24 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory & land at church lane wick road bristol. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 nov 2005
    Consegnato il 30 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 27 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a avon works wick bristol - AV115673. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 27 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Avon works wick bristol. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 27 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 ago 1988
    Consegnato il 06 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage registered pursuant to an order of court dated 20.2.85
    Creato il 05 nov 1984
    Consegnato il 05 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a avonworks, church road, wick, bristol BS15 5PE together and all the buildings & all fixed plant machinery & fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 04 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 ago 1984
    Consegnato il 04 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 set 1981
    Consegnato il 24 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £205,000
    Brevi particolari
    Factory premises with a frontage to church road wick avon.
    Persone aventi diritto
    • St. Regis Paper Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 24 set 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0