TT1 REALISATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TT1 REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | In amministrazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00936239 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TT1 REALISATIONS LIMITED?
- Fabbricazione di altri mobili n.c.a. (31090) / Industrie manifatturiere
Dove si trova TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pricewaterhousecoopers Llp 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TETRAD LIMITED | 08 apr 2009 | 08 apr 2009 |
| TETRAD PLC | 03 mag 1995 | 03 mag 1995 |
| TETRAD ASSOCIATES PUBLIC LIMITED COMPANY | 30 dic 1987 | 30 dic 1987 |
| GIBSON COOPER LIMITED | 29 lug 1968 | 29 lug 1968 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 ott 2025 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 nov 2025 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 ott 2024 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 57 pagine | AM10 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA | 8 pagine | AM02 | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 3 pagine | AM06 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hartford Mill Swan Street Preston Lancashire PR1 5PQ a Pricewaterhousecoopers Llp 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 26 feb 2025 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 99 pagine | AM03 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 3 pagine | AM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed tetrad LIMITED\certificate issued on 20/02/25 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 009362390030, creata il 08 ago 2024 | 72 pagine | MR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 9 pagine | MA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 009362390029, creata il 05 mar 2024 | 21 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 009362390028, creata il 05 mar 2024 | 71 pagine | MR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Christopher Masson come amministratore in data 30 gen 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 009362390027, creata il 28 dic 2023 | 71 pagine | MR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachael Rebecca Nevins come amministratore in data 09 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Thomas Graham Prestwich come amministratore in data 02 nov 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jon Stewart Sharrock come amministratore in data 14 set 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John David Meltham come amministratore in data 23 dic 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ms Rachael Rebecca Nevins come amministratore in data 24 ott 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLETCHER, Christopher John | Amministratore | 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Pricewaterhousecoopers Llp West Yorkshire | England | British | 135851640001 | |||||
| PRESTWICH, Thomas Graham | Amministratore | 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Pricewaterhousecoopers Llp West Yorkshire | United Kingdom | British | 332261350001 | |||||
| SHARROCK, Jon Stewart | Amministratore | 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Pricewaterhousecoopers Llp West Yorkshire | England | British | 188390640001 | |||||
| KING, Catherine Margaret | Segretario | Conifers6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston | British | 35158250002 | ||||||
| LODGE, Carmel | Segretario | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | British | 134598710001 | ||||||
| LOW, George Robert | Segretario | Westbrook Lodge 15 Main Road, Bolton Le Sands LA5 8DQ Carnforth Lancashire | English | 85000610001 | ||||||
| ALLAN-HARDING, Susan | Amministratore | Swan Street PR1 5PQ Preston Hartford Mill England | United Kingdom | British | 183911590001 | |||||
| BORTHWICK, Iain Alexander | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 181980960001 | |||||
| BURKE, Maurice Prentice | Amministratore | Chalet Panorima Postfach 147 FOREIGN Ch-3780 Gstaad Switzerland | Canadian | 31133730001 | ||||||
| COOPER, Janus Robert | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 124673700001 | |||||
| COOPER, Michael James | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 93343230001 | |||||
| COOPER, Robert Gerald | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 6126720004 | |||||
| EVANS, Grenville Alun | Amministratore | 72 Camberley Drive OL11 4BA Rochdale Lancashire | England | British | 77471580001 | |||||
| GRIFFIN, Martin Edward | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 20137790006 | |||||
| HAMPTON, Stephen Raymond | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 127114430002 | |||||
| KING, Catherine Margaret | Amministratore | Conifers6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston | England | British | 35158250002 | |||||
| KING, Laurence | Amministratore | Conifers 6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston Lancashire | England | British | 51624810001 | |||||
| LANGAN, Fiona Jean | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 160333500001 | |||||
| LASHAM, Gary | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 102512840002 | |||||
| LOW, George Robert | Amministratore | Westbrook Lodge 15 Main Road, Bolton Le Sands LA5 8DQ Carnforth Lancashire | England | English | 85000610001 | |||||
| MASSON, Stuart Christopher | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 243645430001 | |||||
| MELTHAM, John David | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 257833640001 | |||||
| NEVINS, Rachael Rebecca | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 177502610001 | |||||
| OTOOLE, Anthony Jeffrey | Amministratore | 25 Arbour Street PR8 6SB Southport Merseyside | British | 26553960001 | ||||||
| PICKUP, Andrew David | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | English | 168397370001 | |||||
| SHERLIKER, Peter Francis | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 155519810001 | |||||
| STEVENS, Karl Ivor | Amministratore | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 133771870001 | |||||
| WILLIAMS, John Albert | Amministratore | 11 The Chase Leyland Preston Lancashire | England | British | 26729820002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfield Group Limited | 13 ago 2021 | Hallam Fields Road DE7 4AZ Ilkeston C/O Belfield Furnishings Limited England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Belfield Furnishings Limited | 17 lug 2017 | Furnace Road DE7 5EP Ilkeston Site 3 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Janus Robert Cooper | 06 apr 2016 | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TT1 REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0