GEORGE PAYNE & CO LIMITED
Panoramica
Nome della società | GEORGE PAYNE & CO LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00940060 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Trinity Park House Fox Way WF2 8EE Wakefield West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BEVERLEY HOUSE (4000) LIMITED | 19 lug 1994 | 19 lug 1994 |
READY ROASTED CHICKENS LIMITED | 07 ott 1968 | 07 ott 1968 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 lug 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 lug 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Ronald Klaas Otto Kers come amministratore in data 26 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanne Caroline Kershaw Simmonds come amministratore in data 22 mag 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 gen 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 14 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 ago 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Craig Ashley Tomkinson il 29 mar 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 lug 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 lug 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn Paul Fletcher come amministratore in data 31 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Craig Ashley Tomkinson come amministratore in data 30 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMMONDS, Joanne Caroline Kershaw | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 309294840001 | ||||
TOMKINSON, Craig Ashley | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire | United Kingdom | British | Group Cfo | 199432160002 | ||||
BUCKLEY, Michael Henry | Segretario | Ewood Farmhouse Greaves Lane Edingley NG22 8BN Newark Nottinghamshire | British | Financial Director | 79170660001 | |||||
HALL, Linda Jane | Segretario | 18 Longland Lane Whixley YO26 8BB York North Yorkshire | British | Assistant Company Secretary | 108998900001 | |||||
HARRIS, Frances Susan | Segretario | 3 The Moorings Ings Lane HU14 3ED North Ferriby East Yorkshire | British | Assistant Company Secretary | 48486630001 | |||||
HILL, Robert Christopher | Segretario | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | British | Assistant Compnay Secretary | 72684940002 | |||||
LAYCOCK, Pauline | Segretario | Beverley House Saint Stephens Square HU1 3XD Hull North Humberside | British | Assistant Company Secretary | 91382980001 | |||||
QUAYLE, Huan | Segretario | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire United Kingdom | 150124310001 | |||||||
SALISBURY, Francis John | Segretario | 13 Castle Rise Ridgewood TN22 5UN Uckfield East Sussex | British | 2989070001 | ||||||
SIMPSON, David Gray | Segretario | 3 Chapel Close Skidby HU16 5TJ Cottingham East Yorkshire | British | Administrator | 1636300001 | |||||
BUCKLEY, Michael Henry | Amministratore | Ewood Farmhouse Greaves Lane Edingley NG22 8BN Newark Nottinghamshire | England | British | Financial Director | 79170660001 | ||||
CLARK, Peter John | Amministratore | The Lodge Belvoir Lane Woolsthorpe By Belvoir NG32 1NQ Grantham Lincs | British | Managing Director | 27887920001 | |||||
DAVIES, Gareth Wyn | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire | England | British | Accountant | 109674760001 | ||||
DICKS, John Malcolm James | Amministratore | Beverley House St Stephens Square HU1 3XD Hull North Humberside | British | Managing Director | 1705180002 | |||||
FLETCHER, Martyn Paul | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire | United Kingdom | British | Coo | 235080230001 | ||||
HALL, Linda Jane | Amministratore | 18 Longland Lane Whixley YO26 8BB York North Yorkshire | United Kingdom | British | Assistant Company Secretary | 108998900001 | ||||
HARRIS, Frances Susan | Amministratore | 3 The Moorings Ings Lane HU14 3ED North Ferriby East Yorkshire | British | Assistant Company Secretary | 48486630001 | |||||
HENDERSON, Stephen | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire United Kingdom | England | British | Financial Controller | 103853510001 | ||||
HILL, Robert Christopher | Amministratore | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Assistant Compnay Secretary | 72684940002 | ||||
KERS, Ronald Klaas Otto, Mr. | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire | England | Dutch | Group Ceo | 170539300001 | ||||
LAYCOCK, Pauline | Amministratore | Beverley House Saint Stephens Square HU1 3XD Hull North Humberside | British | Assistant Company Secretary | 91382980001 | |||||
LEADBEATER, Stephen Paul | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire United Kingdom | England | British | Group Cfo | 84487230001 | ||||
MADDOCK, Michael | Amministratore | Anniversary Cottage The Moor Reepham NR10 4NL Norwich Norfolk | British | Managing Director | 48626180002 | |||||
MORGAN, David Steven | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire United Kingdom | Uk | British | Solicitor | 169577690002 | ||||
PIKE, Richard Neil | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire | United Kingdom | British | Group Cfo | 236794290001 | ||||
QUAYLE, Huan | Amministratore | Fox Way WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Assistant Company Secretary | 150042460001 | ||||
SALISBURY, Francis John | Amministratore | 13 Castle Rise Ridgewood TN22 5UN Uckfield East Sussex | British | Financial Controller | 2989070001 | |||||
SERVINI, Gabriel | Amministratore | Highbury House Werfa Lane Abernant Aberdare Mid Glamorgan | British | Jt Managing Director | 16049240001 | |||||
SERVINI, Robert | Amministratore | Summerfield House Plasdraw CF44 0NS Aberdare Mid Glamorgan | United Kingdom | British | Jt Managing Director | 16433720001 | ||||
SIMPSON, David Gray | Amministratore | 3 Chapel Close Skidby HU16 5TJ Cottingham East Yorkshire | British | Administrator | 1636300001 | |||||
WILD, Julian Nicholas | Amministratore | 226 Westella Road Westella HU10 7RS Hull East Yorkshire | England | British | Company Secretary | 62858980002 | ||||
WILD, Julian Nicholas | Amministratore | 226 Westella Road Westella HU10 7RS Hull East Yorkshire | England | British | Company Secretary | 62858980002 | ||||
WILLIAMS, Carol | Amministratore | Century Way, Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 2180 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 97385290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GEORGE PAYNE & CO LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Foods Limited | 06 apr 2016 | Trinity Business Park WF2 8EE Wakefield Trinity Park House West Yorkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
GEORGE PAYNE & CO LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 12 giu 1984 Consegnato il 18 giu 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold land at harriet street, trecynon, aberdare. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 mar 1980 Consegnato il 18 mar 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land situate at trecynon, mid-glam. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 giu 1979 Consegnato il 14 giu 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all buildings,fixtures plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 nov 1975 Consegnato il 18 dic 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 942 sq.yards at cwmbach,aberdare,mid glamorgan. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0