RCW2000 LIMITED
Panoramica
Nome della società | RCW2000 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00940159 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RCW2000 LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere
Dove si trova RCW2000 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 7 Laureate Paddocks CB8 0AP Newmarket England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RCW2000 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HALDO DEVELOPMENTS LIMITED | 08 ott 1968 | 08 ott 1968 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RCW2000 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per RCW2000 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 28 dic 2020 al 27 dic 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 dic 2019 al 28 dic 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Mr Ricardo Constantine Wildridge come persona con controllo significativo il 01 giu 2020 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Alison Jane Hall il 01 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ricardo Constantine Wildridge il 01 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Alison Jane Hall il 01 giu 2020 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Mr Ricardo Constantine Wildridge come persona con controllo significativo il 01 giu 2020 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 7 Laureate Industrial Estate Newmarket CB8 0AP England a 7 Laureate Paddocks Newmarket CB8 0AP in data 02 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2017 al 29 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Holly Lodge the Street Fornham St. Martin Bury St. Edmunds IP31 1SW England a 7 Laureate Industrial Estate Newmarket CB8 0AP in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1 Western Way West Bury St Edmunds Suffolk IP33 3SP United Kingdom a Holly Lodge the Street Fornham St. Martin Bury St. Edmunds IP31 1SW in data 27 feb 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AAMD | ||||||||||
Cessazione della carica di Terrence Matthew Meanwell come amministratore in data 09 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RCW2000 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL, Alison Jane | Segretario | Laureate Paddocks CB8 0AP Newmarket 7 England | British | 63089830003 | ||||||
HALL, Alison Jane | Amministratore | Laureate Paddocks CB8 0AP Newmarket 7 England | England | British | Financial Director | 63089830005 | ||||
WILDRIDGE, Ricardo Constantine | Amministratore | Laureate Paddocks CB8 0AP Newmarket 7 England | England | British | Chairman | 11102220005 | ||||
BUTCHER, Neil Martin | Segretario | 46 Lowry Way IP14 1UF Stowmarket Suffolk | British | 45195780001 | ||||||
MERRITT, David John | Segretario | 21 Sharp Road IP33 2NB Bury St Edmunds Suffolk | British | 37762780002 | ||||||
WILDRIDGE, Katie | Segretario | The Fort Sicklesmere Road IP33 2BN Bury St Edmunds Suffolk | British | 11102210001 | ||||||
BIRD, Frederick Frank | Amministratore | 46 Fallowfield Walk IP33 2QS Bury St Edmunds Suffolk | British | Technical Director | 98823600001 | |||||
HATSON, Brian Douglas | Amministratore | Allsorts Chimney Mills West Stow IP28 6ES Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Photographer | 22935340001 | ||||
MARWOOD, Hubert Trevor Dalrymple | Amministratore | East Lodge Park Road HP23 6BU Tring Hertfordshire | British | Company Director Consultant Engineer | 11102240001 | |||||
MEANWELL, Terrence Matthew | Amministratore | Western Way West IP33 3SP Bury St Edmunds Unit 1 Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 204249540001 | ||||
SMITH, Ian | Amministratore | Leabrook Close IP32 7JH Bury St Edmunds 22 Suffolk | United Kingdom | British | Managing Director | 123678530001 | ||||
WILDRIDGE, Deborah Elizabeth | Amministratore | 3 Rectory Meadow Rattlesden IP28 6JR Bury St Edmunds Suffolk | British | Company Director | 78929060001 | |||||
WILDRIDGE, Katie | Amministratore | The Fort Sicklesmere Road IP33 2BN Bury St Edmunds Suffolk | British | Company Director | 11102210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RCW2000 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Ricardo Constantine Wildridge | 06 apr 2016 | Laureate Paddocks CB8 0AP Newmarket 7 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
|
RCW2000 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 19 set 2012 Consegnato il 22 set 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land and buildings k/a haldo house western way bury st edmunds suffolk t/no SK145380. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 dic 2006 Consegnato il 15 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 dic 2006 Consegnato il 09 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a haldo house western way bury st edmunds suffolk t/no SK145380. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 mag 2003 Consegnato il 29 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 28 ott 1994 Consegnato il 11 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a western way (also known as moore paragon site) at bury st edmunds suffolk and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 mag 1981 Consegnato il 04 giu 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets preset and future including goodwill & bookdebts including f/hold land and buildings off farnham road, bury st. Edmunds and all the companys right title and interest in the access road to them. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
RCW2000 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0