BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.

BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00940512
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BEAUMONTS (BRADFORD) LIMITED14 ott 196814 ott 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 set 2019

    12 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 set 2018

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Hillside Court Bowling Hill Chipping Sodbury Bristol BS37 6JX a Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD in data 08 ott 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Christopher Bland il 14 gen 2016

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Marsh Secretarial Services Limited come segretario in data 05 lug 2017

    2 pagineAP04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    24 pagineAA

    Cessazione della carica di Craig Arthur Seed come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Christopher Chessher come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Victoria Barker come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Caroline Wendy Godwin come amministratore in data 05 lug 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr James Michael Pickford come amministratore in data 05 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tom Taylor come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dawn Jeanette Hodges come segretario in data 05 lug 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Anthony Weil come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Christopher Bland come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Andrew Barton come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sally Angela Helen Williams come amministratore in data 05 lug 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Andrew Barton il 17 mar 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    21 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARSH SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione555848
    187854670001
    GODWIN, Caroline Wendy
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    Amministratore
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    United KingdomBritish224445640001
    PICKFORD, James Michael
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    Amministratore
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    United KingdomBritish223405040001
    BLAND, Simon Christopher
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    Segretario
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    British78192630002
    CONNEW, Jean Pamela
    Garth Cottage Trip Lane
    Linton
    LS22 4HX Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    Garth Cottage Trip Lane
    Linton
    LS22 4HX Wetherby
    West Yorkshire
    British16778630001
    HARDING, John
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Segretario
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    193531010001
    HODGES, Dawn Jeanette
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1 Tower Place
    England
    Segretario
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1 Tower Place
    England
    203581030001
    HOWARD, Michael Anthony
    3 Old Langley Lane
    Baildon
    BD17 6SG Shipley
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Old Langley Lane
    Baildon
    BD17 6SG Shipley
    West Yorkshire
    British11264260001
    ALWAY, Alexander Douglas
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    EnglandBritish54126880001
    ANDREWS, David William
    18 Kendall Avenue
    BD18 4DU Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    18 Kendall Avenue
    BD18 4DU Shipley
    West Yorkshire
    British23239450001
    BARKER, Jane Victoria
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Amministratore
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    United KingdomBritish4552270004
    BARTON, Philip Andrew
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    EnglandBritish12624970004
    BLAND, Simon Christopher
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    EnglandBritish78192630012
    CHESSHER, Mark Christopher
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1 Tower Place
    England
    Amministratore
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1 Tower Place
    England
    United KingdomBritish164148230004
    CONNEW, Jean Pamela
    Garth Cottage Trip Lane
    Linton
    LS22 4HX Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Garth Cottage Trip Lane
    Linton
    LS22 4HX Wetherby
    West Yorkshire
    British16778630001
    CONNEW, Roy
    Garth Cottage
    Trip Lane Lynton
    Wetherby
    W Yorks
    Amministratore
    Garth Cottage
    Trip Lane Lynton
    Wetherby
    W Yorks
    British11264280001
    COSTELLO, Phillip
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    Amministratore
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    EnglandBritish76075000010
    CUBITT, David Leslie
    Hilltop 17 Glen Road
    Eldwick
    BD16 3EU Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hilltop 17 Glen Road
    Eldwick
    BD16 3EU Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish11264270001
    CUBITT, David Leslie
    Hilltop 17 Glen Road
    Eldwick
    BD16 3EU Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hilltop 17 Glen Road
    Eldwick
    BD16 3EU Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish11264270001
    DAVIES, David Tudor
    Low Fold
    Carters Lane, Middleton
    LS29 0DQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Low Fold
    Carters Lane, Middleton
    LS29 0DQ Ilkley
    West Yorkshire
    British14319170004
    DURANT, Neil Andrew
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    Amministratore
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    EnglandBritish67375200004
    FRISKNEY, Charles
    Orchard House 3 Avon Garth
    Linton Lane Linton
    LS22 6HH Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Orchard House 3 Avon Garth
    Linton Lane Linton
    LS22 6HH Wetherby
    West Yorkshire
    British81637890001
    GEELAN, William Terence
    29 Moor Croft
    Eldwick
    BD16 3DR Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    29 Moor Croft
    Eldwick
    BD16 3DR Bingley
    West Yorkshire
    British40679840001
    HARDING, John Trevor
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    EnglandBritish99783690002
    HARRIS, Colin Michael
    Orchard House 8 Fyfe Grove
    Baildon
    BD17 6DN Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Orchard House 8 Fyfe Grove
    Baildon
    BD17 6DN Shipley
    West Yorkshire
    British5836940001
    HINDLE, Michael
    17 Dicks Garth Road
    Menston
    LS29 6HF Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Dicks Garth Road
    Menston
    LS29 6HF Ilkley
    West Yorkshire
    British36338900001
    HINDLE, Michael
    17 Dicks Garth Road
    Menston
    LS29 6HF Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Dicks Garth Road
    Menston
    LS29 6HF Ilkley
    West Yorkshire
    British36338900001
    HOWARD, Michael Anthony
    3 Old Langley Lane
    Baildon
    BD17 6SG Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Old Langley Lane
    Baildon
    BD17 6SG Shipley
    West Yorkshire
    Great BritainBritish11264260001
    HOWARD, Michael Anthony
    3 Old Langley Lane
    Baildon
    BD17 6SG Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Old Langley Lane
    Baildon
    BD17 6SG Shipley
    West Yorkshire
    Great BritainBritish11264260001
    LAMBORN, Richard Ian William
    Pond Cottage
    Angram
    YO2 3PA York
    Amministratore
    Pond Cottage
    Angram
    YO2 3PA York
    United KingdomBritish38276380001
    LUX, Howard Peregrine
    Dodle Farm
    Denshaw
    OL3 5RP Saddleworth
    Amministratore
    Dodle Farm
    Denshaw
    OL3 5RP Saddleworth
    EnglandBritish85669560001
    SEED, Craig Arthur
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    EnglandBritish66855780015
    SILVERMAN, Damian
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    United KingdomBritish78194120003
    STOTT, Anthony Grahame
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Amministratore
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    EnglandBritish110186050001
    SYKES, Martin
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    Amministratore
    12 Trevor Foster Way
    Bradford
    BD5 8HB West Yorkshire
    United KingdomBritish76075120006

    Chi sono le persone con controllo significativo di BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Beaumonts Bradfordlimited
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    06 apr 2016
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione4267579
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 dic 2014
    Consegnato il 22 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H unit f 12 trevor foster way bradford t/no WYK846911. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security debenture
    Creato il 17 lug 2009
    Consegnato il 05 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macquarie Bank Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 06 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2008
    • 10 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 13 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 24 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £365,021 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Beaumonts (Life & Pension Consultants) Limited
    Transazioni
    • 24 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 clifton villas manningham bradford west yorkshire t/n-WYK110669.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 13 set 1999
    Consegnato il 22 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and beaumonts (life & pension consultants) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Residual floating charge
    Creato il 30 nov 1992
    Consegnato il 09 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floating charge over the undertaking and all its property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1992
    Consegnato il 03 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land together with buildings erected thereon k/a 1 clifton villas manningham bradford west yorkshire t/n wyk 110669 assigns the goodwill of the business and the full benefit of all present and future licences held in connection with the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BEAUMONTS INSURANCE BROKERS LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 set 2018Inizio della liquidazione
    14 lug 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Praticante
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0