00944891 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società00944891 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00944891
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 00944891 LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova 00944891 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o SAPA BUILDING SYSTEMS LIMITED
    5300 Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 00944891 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCANDINAVIAN ALUMINIUM PROFILES AB LIMITED24 dic 196824 dic 1968

    Quali sono gli ultimi bilanci di 00944891 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 00944891 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per 00944891 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sapa\certificate issued on 25/11/15
    pagineCERTNM

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da * Alexandra Way Ashchurch Tewkesbury Gloucestershire GL20 8NB* in data 22 giu 2011

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 feb 2011

    Stato del capitale al 01 feb 2011

    • Capitale: GBP 2,086,534
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Keith Sissons il 31 gen 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2005

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2004

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2003

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di 00944891 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    British24297480001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish24297480001
    SISSONS, Nigel Keith
    c/o Sapa Building Systems Limited
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    5300
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Sapa Building Systems Limited
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    5300
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish80321870001
    MILTON, Raymond George
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British30257980002
    POWELL, Dominic Hugh
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    Segretario
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    British24124960001
    BERGENHEM, Lars
    9 Headfort Place
    SW1 7DE London
    Amministratore
    9 Headfort Place
    SW1 7DE London
    Swedish78626550001
    ELLIOTT, Leslie Charles
    5 Parkside Drive
    Long Eaton
    NG10 4AL Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    5 Parkside Drive
    Long Eaton
    NG10 4AL Nottingham
    Nottinghamshire
    British3825910001
    GREENSLADE, Robin Alastair
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    British4565340001
    HERRINGTON, Hugh Richard
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish6360950001
    JOHANSSON, Mats Harald
    4 Paddocks View
    Long Eaton
    NG10 3QF Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    4 Paddocks View
    Long Eaton
    NG10 3QF Nottingham
    Nottinghamshire
    Swedish68575210001
    KEIJZER, Peter
    Volmachtenlaan 11 9331 Bk
    FOREIGN Norg
    Holland
    Amministratore
    Volmachtenlaan 11 9331 Bk
    FOREIGN Norg
    Holland
    Dutch24124970001
    MILTON, Raymond George
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British30257980002
    MITCHELL, John
    23 Badgers Chase
    Tiln Lane
    DN22 6RX East Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    23 Badgers Chase
    Tiln Lane
    DN22 6RX East Retford
    Nottinghamshire
    British60169480002
    POWELL, Dominic Hugh
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    British24124960001
    WHARMBY, Roger
    Twyn Trees 188 High Street
    Tibshelf
    DE55 5NE Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    Twyn Trees 188 High Street
    Tibshelf
    DE55 5NE Alfreton
    Derbyshire
    EnglandBritish52838660001

    00944891 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of set-off
    Creato il 16 mar 1984
    Consegnato il 16 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 14 mar 1983
    Acquisito il 30 giu 1983
    Consegnato il 18 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Nil at present
    Brevi particolari
    The property as charged in the mortgage debenture dated 14TH march 1983 (please see doc M46).
    Persone aventi diritto
    • London Interstate Bank Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 14 mar 1983
    Consegnato il 30 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over land and bldgs lying to the south of manefield road, sawpit lane, tibshelf derbyshire title no dy 63242 and land at sawpit lane tibshelf derbyshire described in conveyance s dated 21.9.72 and 3.2.75 fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts uncalled capital. All stocks, shares and other interests, all patents, patent applications trade monies trade names etc. tog with all fixtures (inc-trade fixtures) fixed plant & machinery. (See doc-M41).
    Persone aventi diritto
    • London Interstate Bank Limited
    Transazioni
    • 30 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 22 ott 1981
    Consegnato il 23 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H & l/h properties present & future with fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery goodwill & uncalled capital present & future undertaking all other property & assets present & future inc heritable property & assets in scotland fixed & floating charge (see doc M40).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 27 lug 1981
    Consegnato il 04 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over f/h land at sawpit lane tibshelf, derbyshire title no dy 63242 tog with all other f/h & l/h property of the company present & future inc. All fixtures, fixed plant & machinery. All stocks, shares etc. uncalled capital goodwill patents trade marks etc. all book & other debts floating charge over the undertaking & all other property assets & rights.
    Persone aventi diritto
    • Scandinavian Bank Limited
    Transazioni
    • 04 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture as varied by a deed of variation dated 22ND october 1981
    Creato il 05 ago 1980
    Acquisito il 30 giu 1983
    Consegnato il 20 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Nil at present
    Brevi particolari
    The property as charged in the mortgage debenture dated 5TH august 1980 as varied by the dee dof variation dated 22ND october 1981 (please see doc M47).
    Persone aventi diritto
    • Scandinavian Bank Limited
    Transazioni
    • 20 lug 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0