HEWDEN SERVICES LIMITED

HEWDEN SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEWDEN SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00947454
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEWDEN SERVICES LIMITED?

    • (4550) /
    • (7134) /

    Dove si trova HEWDEN SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Trafford House Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RL Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEWDEN SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GATEWAY PLANT HOLDINGS LIMITED06 feb 196906 feb 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEWDEN SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per HEWDEN SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2010

    Stato del capitale al 14 lug 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Susan Shardlow il 20 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin Parkes il 20 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Susan Shardlow il 20 giu 2010

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da Finning Uk Ltd Watling Street Cannock Staffordshire WS11 8LL in data 02 giu 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Nomina di Susan Shardlow come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Douglas Sprout come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Douglas Sprout come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Dickinson come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Davies come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Susan Shardlow come segretario

    3 pagineAP03

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di HEWDEN SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHARDLOW, Susan
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    Segretario
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    British151299860001
    PARKES, Kevin
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    Amministratore
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United KingdomBritish146059290002
    SHARDLOW, Susan
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    Amministratore
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United KingdomBritish151325710002
    DEAKIN, Alastair Wright
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    Segretario
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    British63127160001
    NETHERWAY, Robert William
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Segretario
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    British30995760008
    SPROUT, Douglas
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    England
    Segretario
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    England
    British149542050001
    DAVIES, Michael
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Amministratore
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    United KingdomBritish140297230001
    DEAKIN, Alastair Wright
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    Amministratore
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    ScotlandBritish63127160001
    DICKINSON, Neil Robert
    C/O Finning (Uk) Ltd.
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    C/O Finning (Uk) Ltd.
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomBritish102224030002
    FINDLAY, Alexander Fraser
    Pitfour 1 Leewood Park
    FK15 0NX Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Pitfour 1 Leewood Park
    FK15 0NX Dunblane
    Perthshire
    British634480001
    HOTCHKISS, Colin Archibald
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Amministratore
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Canadian133634850001
    JARVIS, Paul James Christopher
    49 Oatlands Avenue
    KT13 9SS Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    49 Oatlands Avenue
    KT13 9SS Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish2293800001
    LLOYD, Nicholas Bradley
    Hewden, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Amministratore
    Hewden, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    British91982390004
    LYON, Hamish Angus
    Broom Cottage 17hillcrest Drive
    Newton Mearns
    G77 5HH Glasgow
    Amministratore
    Broom Cottage 17hillcrest Drive
    Newton Mearns
    G77 5HH Glasgow
    British58265340001
    NAPIER, Alistair George St Clair
    33/13 Murrayfield Road
    EH12 6EP Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    33/13 Murrayfield Road
    EH12 6EP Edinburgh
    Scotland
    British57915070001
    NETHERWAY, Robert William
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Amministratore
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    United KingdomBritish30995760008
    QUENBY, Roger Brian
    1 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    1 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish636400001
    SHERLOCK, Brian Foster
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Amministratore
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    British107903020002
    SPROUT, Douglas
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomCanadian149547490001

    HEWDEN SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of offset
    Creato il 28 ago 1999
    Consegnato il 15 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or the other companies named therein
    Brevi particolari
    The total of the amounts from time to time at the credit of all accounts held with the bank in the name of the granter.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Letter of offset
    Creato il 16 nov 1993
    Consegnato il 30 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of hewden services limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 lug 1969
    Consegnato il 21 lug 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £54,165
    Brevi particolari
    Various items of machinery (see schedule attached to doc 16 for details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds & Scottish Trust LTD
    Transazioni
    • 21 lug 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 16 giu 1969
    Consegnato il 18 giu 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £22,800 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new coles model hydra truck super 120 (t) diesel hydraulic crane one new priestman BC72 crane and ancillary equipment.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 18 giu 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1969
    Consegnato il 25 apr 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £16000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Two J.C.B. hydraulic excavators serial nos 70618/70625.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 25 apr 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1969
    Consegnato il 25 apr 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10000 and all other monies due or to become due form the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One 22RB 1.C.D. diesel lift crane and attachments madine no 22RB, 33376.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 25 apr 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1969
    Consegnato il 25 apr 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £13740 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    One coles hydra husky serial no 26267.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 25 apr 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 apr 1969
    Consegnato il 09 apr 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £47,890
    Brevi particolari
    Various items of machinery as per schedule attached to doc 10.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds & Scottish Trust LTD
    Transazioni
    • 09 apr 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 mar 1969
    Consegnato il 21 mar 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,880
    Brevi particolari
    1 new caterpillar D6C tractor 2411 gauge direct diesel model with ancillary equipment, 6A bulldozer and 1 new caterpiller, see doc M9 for further details please.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds & Scottish Trust LTD
    Transazioni
    • 21 mar 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 feb 1969
    Consegnato il 27 feb 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £86,476
    Brevi particolari
    Various items of machinery see doc 8 for details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds & Scottich Trsut LTD
    Transazioni
    • 27 feb 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0