LEASED HOTELS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LEASED HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00955200 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LEASED HOTELS LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova LEASED HOTELS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LEASED HOTELS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LEASED HOTELS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 15 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Bruce Robinson come amministratore in data 14 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AQ a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Queen Street Place London EC4R 1AQ | 3 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Queen Street Place London EC4R 1AQ | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 21 dic 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Michael Teasdale il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 18 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 009552000005 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 03 lug 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 03 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LEASED HOTELS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Segretario | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | British | 49678170001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Segretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Segretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203651940001 | |||||||||||
| MASON, Timothy Charles | Segretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
| MILLS, John Michael | Segretario | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||||||
| RUSSELL, Thomas | Segretario | 91 Lauderdale Tower EC2Y 8BY London | British | 206020001 | ||||||||||
| STEVENS, David John | Segretario | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Segretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Segretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Segretario | Ten Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London 10 United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Amministratore | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||||||
| DURBAN, Donald Desmond | Amministratore | 54 Foxes Dale Blackheath SE3 9BQ London | British | 7480200001 | ||||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Amministratore | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Amministratore | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| FORTE, Charles, Lord | Amministratore | Lowndes House Lowndes Place Belgrave Square SW1X 8DB London | British | 16307450001 | ||||||||||
| HEDGES, Peter | Amministratore | Coddimoor Farm MK17 0LR Whaddon Buckinghamshire | United Kingdom | British | 34130540001 | |||||||||
| JOHNSTON, Alexander, Sir | Amministratore | 18 Mallord Street Chelsea SW3 6DU London | British | 16063980001 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Amministratore | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Amministratore | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| MILLARD, Derek Herbert Henry | Amministratore | Bracken House Scaynes Hill RH17 7NH Haywards Heath Sussex | British | 4546520001 | ||||||||||
| MITCHELL, Paul Raymond | Amministratore | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | 148147140001 | |||||||||
| NEWMAN, Mark | Amministratore | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PARROTT, Graham Joseph | Amministratore | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | 6741720003 | ||||||||||
| PRINCE, Ryan David | Amministratore | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| PROCTOR, George Frederick Little | Amministratore | The Tile House 35 Main Avenue Moor Park HA6 2LH Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 2262240001 | |||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Amministratore | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Amministratore | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LEASED HOTELS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nas Cobalt No.2 Limited | 06 apr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LEASED HOTELS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 dic 2015 Consegnato il 02 dic 2015 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 mag 2013 Consegnato il 03 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione L/H holiday inn swindon posthouse marlborough road swinsdon t/no WT242680. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 28 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 22 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 apr 1970 Consegnato il 05 mag 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee including all monies due under an agreement dated 25TH june, 1969. | |
Brevi particolari Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LEASED HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0