FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED

FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00955243
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED?

    • Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o COMPANY SECRETARY
    Berkshire Media Group
    50-56 Portman Road
    RG30 1BA Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Charles John Allwood come amministratore in data 22 mag 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 28 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Thomson Morrison il 01 feb 2013

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham John Faulds il 01 mar 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 29 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 01 ott 2011

    6 pagineAA

    legacy

    9 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    28 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di William Shields Henderson come amministratore in data 27 feb 2012

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Graham John Faulds come amministratore in data 27 feb 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Charles John Allwood come amministratore in data 27 feb 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Graham Thomson Morrison come amministratore in data 27 feb 2012

    3 pagineAP01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FAULDS, Graham John
    Danes Drive
    G14 9HX Glasgow
    61
    United Kingdom
    Segretario
    Danes Drive
    G14 9HX Glasgow
    61
    United Kingdom
    151592740001
    FAULDS, Graham John
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    Amministratore
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish63911030001
    MORRISON, Graham Thomson
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    Amministratore
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish58322450001
    LAWRANCE, Brenda Jane
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    Segretario
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    British10757530001
    ROMANES, Deirdre Mary Astrea
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Segretario
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Irish3206310002
    ALLWOOD, Charles John
    Charles Street
    HP4 3DG Berkhamsted
    3
    Hertfordshire
    Amministratore
    Charles Street
    HP4 3DG Berkhamsted
    3
    Hertfordshire
    EnglandBritish35681240004
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish55090001
    LAWRANCE, Brenda Jane
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Old Quakers House
    Hedgerley Village
    SL2 3UY Slough
    Berkshire
    British10757530001
    LAWRANCE, Peter John
    Shears Bank
    HR8 1EE Ledbury
    .
    Herefordshire
    Uk
    Amministratore
    Shears Bank
    HR8 1EE Ledbury
    .
    Herefordshire
    Uk
    United KingdomBritish10757540004
    MURES, Donald John
    61 Eastfield Road
    SL1 7EL Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    61 Eastfield Road
    SL1 7EL Burnham
    Buckinghamshire
    British11126210001
    ROMANES, Deirdre Mary Astrea
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Amministratore
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    United KingdomIrish3206310002
    ROMANES, Iain Blair
    Hillside House
    Saline
    KY12 9TD Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    Hillside House
    Saline
    KY12 9TD Dunfermline
    Fife
    British182800001

    FRANK LAWRANCE(SLOUGH OBSERVER)LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 apr 2012
    Consegnato il 25 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 06 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 loan facility as set out in a loan facility letter of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brenda Lawrance
    • Peter John Lawrance
    Transazioni
    • 06 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 gen 1993
    Consegnato il 26 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1991
    Consegnato il 19 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book and other debts of the company present and future see form 395 (ref 218) and/or for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 19 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 08 mag 1990
    Consegnato il 09 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H units 3-5 phase 34 gillingham business park gillingham kent.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 mar 1989
    Consegnato il 19 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £341,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Property k/a units no.3-5 Phase 34 (valentine close) gillingham business park gillingham kent & also the full benefit of a building agreement.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 ago 1981
    Consegnato il 27 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties. Fixed and floating chage over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 ago 1981
    Consegnato il 27 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 courtlands avenue slough, berkshire title no: bm 1284. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 lug 1980
    Consegnato il 23 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as 7 crown shopping centre slough, berkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0