PENDRAGON EXTRA LIMITED

PENDRAGON EXTRA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPENDRAGON EXTRA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00956104
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    • Noleggio e leasing di automobili e veicoli a motore leggeri (77110) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXTRA LEASING LIMITED04 feb 199704 feb 1997
    LONG TRUCK SERVICES LIMITED10 ott 198310 ott 1983
    OCEAN TRUCK SERVICES LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    HENRY LONG (ROPES & COVERS) LIMITED12 giu 196912 giu 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A7JTTD13

    legacy

    1 pagineSH20
    S7JTEY8O

    Stato del capitale al 06 dic 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19
    A7JTTD0R

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    A7JTTCZ4

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20
    S7H6E1X4

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    S7H6E1OH

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA
    A7EHPC7O

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X77HPK62

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA
    A6FQ1DBM

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X68G75EI

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01
    X5XVLG9L

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02
    X5XVLFR7

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01
    X5HX0QH6

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 18 ott 2016

    2 pagineCH01
    X5HX0QLU

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01
    X5HX0PPE

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA
    A5GC26WO

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 giu 2016

    Stato del capitale al 08 giu 2016

    • Capitale: GBP 9,250,000
    SH01
    X58OLB2B

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 26 ott 2015

    2 pagineCH01
    X4JV1LD7

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA
    A4GNNEDU

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2015

    Stato del capitale al 10 giu 2015

    • Capitale: GBP 9,250,000
    SH01
    X49AJGJ4

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA
    A3GYK42L

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2014

    Stato del capitale al 05 giu 2014

    • Capitale: GBP 9,250,000
    SH01
    X39DC52P

    Chi sono gli amministratori di PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British110894220002
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector2652610013
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2304195
    110674970001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    British65759080001
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector21483450001
    SKELLY, Mary Angela
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    Segretario
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    British83455820001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector41559790001
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Amministratore
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritishDirector29331220001
    EDWARDS, Raymond Peter
    Crosslands
    Stanbury
    BD22 0HB Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Crosslands
    Stanbury
    BD22 0HB Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector62223380001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    46 Kent Road
    HG1 2ET Harrogate
    North Yorkshire
    England
    BritishDirector65759080001
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglishChartered Accountant107835250001
    HALLIWELL, James Timothy
    Longfield
    Haworth Road Cullingworth
    BD13 5EQ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Longfield
    Haworth Road Cullingworth
    BD13 5EQ Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector6294650002
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector21483450001
    PHILLIPS, Peter
    25 Higher Lane
    WA13 0BA Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    25 Higher Lane
    WA13 0BA Lymm
    Cheshire
    BritishCompany Director59422220002
    ROSS, John Allan
    Millbeck House Gill Lane
    Rawdon
    LS19 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Millbeck House Gill Lane
    Rawdon
    LS19 7DG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector43839050001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PENDRAGON EXTRA LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Charles Sidney Holdings Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2830974
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PENDRAGON EXTRA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's title rights and interest of whatever nature in and to all the sub hire agreements including, without limitation, the right to receive the sub hire debts.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's title rights and interest of whatever nature in and to all the sub hire agreements including, without limitation, the right to receive the sub hire debts.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 21 giu 2002
    Consegnato il 01 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement and charge
    Creato il 22 giu 1998
    Consegnato il 22 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of any lease purchase, conditional sale or bailment agreement (as defined in the charge) or under the charge
    Brevi particolari
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer (as defined in the charge) and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire ("the sub lessee") whereby the customer lets or agrees to let the goods forming the subject matter of any lease purchase hire purchase conditional sale or bailment agreement to the sub lessee.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited as Principal or as Agent of Any of the Other Companies Specified in Theschedule
    Transazioni
    • 22 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 14TH november 1997
    Creato il 28 mag 1998
    Consegnato il 06 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements and the master assignment
    Brevi particolari
    All monies due under the sub-hire agreements specified in the schedule and benefit of all guarantees,indemnities and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Leasing 4 Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 mag 1998
    Consegnato il 01 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as therein defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    L/H land k/a land and buildings lying to the north west side of hill street rochdale t/n GM2997; l/h land k/a land and buildings on the north west and south sides of summer castle greater manchester t/n GM379700; f/h land k/a land on the south-east side of kenion street rochdale t/n GM4995 and l/h land k/a land and buildings on the north west side of hill street rochdale t/n GM669510. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 14 november 1997
    Creato il 09 apr 1998
    Consegnato il 21 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements entered into from time to time between the chargee and the company and all costs,charges and expenses incurred by the chargee to enforce any of the provisions of the master assignment
    Brevi particolari
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment.the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Leasing 3 Limited
    Transazioni
    • 21 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 25 feb 1998
    Consegnato il 12 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master assignment dated 14TH november 1997
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the sub-lease numbered EOL98/155 with danzas (UK) limited over 2 x leyland daf 55.210 chassis cab reg.no's R847 dtw and R848 dtw, 1 x leyland daf 45.160 chassis cab reg.no;-R846 dtw.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Leasing
    Transazioni
    • 12 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 07 gen 1998
    Consegnato il 10 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master assignment dated 14 nov 97
    Brevi particolari
    The assigned agreements and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Leasing 12 Limited
    Transazioni
    • 10 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 17 nov 1997
    Consegnato il 06 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master agreement dated 14TH november 1997
    Brevi particolari
    1). the "assined agreements" and 2). the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Leasing 11 Limited
    Transazioni
    • 06 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master assignment
    Creato il 20 ott 1997
    Consegnato il 22 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment by way of security of all monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC as Agent for the Owners (As Defined)
    Transazioni
    • 22 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture over contract hire and leasing agreements
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 26 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    Charge over the benefit of related sub hire contracts.
    Persone aventi diritto
    • Hitachi Credit (U.K.) PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all rights and interest of the company in the agreements, all monies now or hereafter payable under the agreements, the goods comprised in the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Group PLC
    • Chartered Leasing Limited
    • Ct Vehicle Leasing Limited
    • Chartered Trust PLC
    • Standard Finance Limited
    • Ctl Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0