GSH 2018 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGSH 2018 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00959122
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GSH 2018 LIMITED?

    • Attività di società holding di produzione (64202) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova GSH 2018 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cheeseburn Grange
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GSH 2018 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GODFREY-SYRETT(HOLDINGS)LIMITED29 lug 196929 lug 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di GSH 2018 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per GSH 2018 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN United Kingdom a Cheeseburn Grange Stamfordham Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE18 0PT in data 22 set 2021

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Joanna Lucy Riddell il 20 set 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Francis Riddell il 20 set 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio modificato di micro-entità redatto al 30 giu 2020

    3 pagineAAMD

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Notifica di Cheeseburn Estate Management Company Limited come persona con controllo significativo il 01 feb 2021

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 11 mar 2021

    2 paginePSC09

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020

    4 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Coburg House 1 Coburg Street Gateshead Tyne and Wear NE8 1NS England a 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN in data 10 gen 2020

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Joanna Lucy Riddell il 15 ott 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Francis Riddell il 15 ott 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2019 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 29 gen 2019

    • Capitale: GBP 50,000
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di GSH 2018 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RIDDELL, Joanna Lucy
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Cheeseburn Grange
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Cheeseburn Grange
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishDirector47335340001
    RIDDELL, Simon Francis
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Cheeseburn Grange
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Cheeseburn Grange
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishCompany Director13102240002
    BILLINGHAM, Craig
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    Segretario
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    193655760001
    CONYERS, Charles Graham
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    Segretario
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    British36079480005
    GREENWELL, David Alistair
    The Inch
    2 St Matthew's Close
    DL8 5HP Leyburn
    North Yorkshire
    Segretario
    The Inch
    2 St Matthew's Close
    DL8 5HP Leyburn
    North Yorkshire
    British5981650004
    MAWER, Richard John Simon
    3 Neasdon Crescent
    Tynemouth
    NE30 2TP North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    3 Neasdon Crescent
    Tynemouth
    NE30 2TP North Shields
    Tyne & Wear
    British6073760001
    POPE, Nicholas Joseph
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    Segretario
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    226833930001
    CONYERS, Charles Graham
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishCompany Director36079480005
    DAY, Hugo Benjamin
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishProperty Consultant63678450002
    DAY, Simon James, Sir
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    EnglandBritishCompany Director12477210001
    GREENWELL, David Jeremy Quentin
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    Amministratore
    Planet Place
    Newcastle Upon Tyne
    NE12 6DY Tyne & Wear
    EnglandBritishRecruiting Consultant164077800002
    GREENWELL, David Alistair
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishCompany Director5981650004
    PETRIE, Neil Crawford
    Sulphur Wells
    Road 11 Masterton
    FOREIGN
    New Zealand
    Amministratore
    Sulphur Wells
    Road 11 Masterton
    FOREIGN
    New Zealand
    BritishCompany Director12477220001
    RANCE, Gabrielle Helene
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishReflexologist75088580002
    RIDDELL, Philip Oriel
    Broomy Hall
    Dalton
    NE18 0DF Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Broomy Hall
    Dalton
    NE18 0DF Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director12477230002
    RUSGA, William Joseph
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritishCompany Director6083010001
    SKELTON, Peter Stephen
    Glen Morven
    Forest Drive Kingswood
    KT20 6LQ Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Glen Morven
    Forest Drive Kingswood
    KT20 6LQ Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director24208610001
    WAKEHAM, Alison Bridget, Lady
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    1 Coburg Street
    NE8 1NS Gateshead
    Coburg House
    Tyne And Wear
    England
    EnglandBritishCompany Director1999660001
    WAKEHAM, Alison Bridget, Lady
    Pinglestone House
    Old Alresford
    SO24 9TB Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Pinglestone House
    Old Alresford
    SO24 9TB Alresford
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director1999660001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GSH 2018 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cheeseburn Estate Management Company Limited
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Cheeseburn Grange Hall
    United Kingdom
    01 feb 2021
    Stamfordham
    NE18 0PT Newcastle Upon Tyne
    Cheeseburn Grange Hall
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione07592329
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GSH 2018 LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    17 mar 201701 feb 2021La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    GSH 2018 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 gen 2015
    Consegnato il 04 feb 2015
    In corso
    Breve descrizione
    By way of legal mortgage all freehold (including commonhold) and leasehold land vested in the company at the date of the debenture together with all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery at the date of the debenture or at any time afterwards on it. This includes (without limitation) land described or referred to in part 1 of the first schedule of the debenture subject only to the other mortgages or matters (if any) mentioned in part 2 of the first schedule of the debenture.. By way of first fixed charge all letters, patents, trade marks, service marks, designs, utility models, copyrights, design rights, applications for registration of any of them and the right to apply for them in any part of the world. In addition, moral rights, inventions, confidential information, know how and rights of a similar nature arising or subsisting anywhere in the world in relation to all or any of the above (whether registered or unregistered) at the date of the debenture or at any time afterwards belonging to the company (together with any of the same mentioned in the second schedule of the debenture, collectively called the "intellectual property").
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0