GSH 2018 LIMITED
Panoramica
Nome della società | GSH 2018 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00959122 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GSH 2018 LIMITED?
- Attività di società holding di produzione (64202) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova GSH 2018 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Cheeseburn Grange Stamfordham NE18 0PT Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GSH 2018 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GODFREY-SYRETT(HOLDINGS)LIMITED | 29 lug 1969 | 29 lug 1969 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GSH 2018 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per GSH 2018 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN | 1 pagine | AD02 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN United Kingdom a Cheeseburn Grange Stamfordham Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE18 0PT in data 22 set 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Joanna Lucy Riddell il 20 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Francis Riddell il 20 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio modificato di micro-entità redatto al 30 giu 2020 | 3 pagine | AAMD | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Notifica di Cheeseburn Estate Management Company Limited come persona con controllo significativo il 01 feb 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 11 mar 2021 | 2 pagine | PSC09 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020 | 4 pagine | AA | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2020 | 1 pagine | AA01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Coburg House 1 Coburg Street Gateshead Tyne and Wear NE8 1NS England a 17 Queens Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 1RN in data 10 gen 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Joanna Lucy Riddell il 15 ott 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Francis Riddell il 15 ott 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2019 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||
Stato del capitale al 29 gen 2019
| 3 pagine | SH19 | ||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||
Chi sono gli amministratori di GSH 2018 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDDELL, Joanna Lucy | Amministratore | Stamfordham NE18 0PT Newcastle Upon Tyne Cheeseburn Grange Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Director | 47335340001 | ||||
RIDDELL, Simon Francis | Amministratore | Stamfordham NE18 0PT Newcastle Upon Tyne Cheeseburn Grange Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Company Director | 13102240002 | ||||
BILLINGHAM, Craig | Segretario | Planet Place Newcastle Upon Tyne NE12 6DY Tyne & Wear | 193655760001 | |||||||
CONYERS, Charles Graham | Segretario | Planet Place Newcastle Upon Tyne NE12 6DY Tyne & Wear | British | 36079480005 | ||||||
GREENWELL, David Alistair | Segretario | The Inch 2 St Matthew's Close DL8 5HP Leyburn North Yorkshire | British | 5981650004 | ||||||
MAWER, Richard John Simon | Segretario | 3 Neasdon Crescent Tynemouth NE30 2TP North Shields Tyne & Wear | British | 6073760001 | ||||||
POPE, Nicholas Joseph | Segretario | Planet Place Newcastle Upon Tyne NE12 6DY Tyne & Wear | 226833930001 | |||||||
CONYERS, Charles Graham | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Company Director | 36079480005 | ||||
DAY, Hugo Benjamin | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Property Consultant | 63678450002 | ||||
DAY, Simon James, Sir | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | England | British | Company Director | 12477210001 | ||||
GREENWELL, David Jeremy Quentin | Amministratore | Planet Place Newcastle Upon Tyne NE12 6DY Tyne & Wear | England | British | Recruiting Consultant | 164077800002 | ||||
GREENWELL, David Alistair | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Company Director | 5981650004 | ||||
PETRIE, Neil Crawford | Amministratore | Sulphur Wells Road 11 Masterton FOREIGN New Zealand | British | Company Director | 12477220001 | |||||
RANCE, Gabrielle Helene | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Reflexologist | 75088580002 | ||||
RIDDELL, Philip Oriel | Amministratore | Broomy Hall Dalton NE18 0DF Newcastle Upon Tyne | British | Company Director | 12477230002 | |||||
RUSGA, William Joseph | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | United Kingdom | British | Company Director | 6083010001 | ||||
SKELTON, Peter Stephen | Amministratore | Glen Morven Forest Drive Kingswood KT20 6LQ Tadworth Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 24208610001 | ||||
WAKEHAM, Alison Bridget, Lady | Amministratore | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House Tyne And Wear England | England | British | Company Director | 1999660001 | ||||
WAKEHAM, Alison Bridget, Lady | Amministratore | Pinglestone House Old Alresford SO24 9TB Alresford Hampshire | England | British | Company Director | 1999660001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GSH 2018 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheeseburn Estate Management Company Limited | 01 feb 2021 | Stamfordham NE18 0PT Newcastle Upon Tyne Cheeseburn Grange Hall United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GSH 2018 LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
17 mar 2017 | 01 feb 2021 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
GSH 2018 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 30 gen 2015 Consegnato il 04 feb 2015 | In corso | ||
Breve descrizione By way of legal mortgage all freehold (including commonhold) and leasehold land vested in the company at the date of the debenture together with all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery at the date of the debenture or at any time afterwards on it. This includes (without limitation) land described or referred to in part 1 of the first schedule of the debenture subject only to the other mortgages or matters (if any) mentioned in part 2 of the first schedule of the debenture.. By way of first fixed charge all letters, patents, trade marks, service marks, designs, utility models, copyrights, design rights, applications for registration of any of them and the right to apply for them in any part of the world. In addition, moral rights, inventions, confidential information, know how and rights of a similar nature arising or subsisting anywhere in the world in relation to all or any of the above (whether registered or unregistered) at the date of the debenture or at any time afterwards belonging to the company (together with any of the same mentioned in the second schedule of the debenture, collectively called the "intellectual property"). L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0