PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00960822
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tempsford Hall
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Bedfordshire
    Great Britain
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARKMAN CONSULTANTS (NIGERIA) LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    WASHPARK LIMITED25 ago 196925 ago 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 10 mag 2017

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    1 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Bethan Melges il 08 dic 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Anoop Kang come amministratore in data 22 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas Lee Foreman come amministratore in data 22 dic 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2016

    Stato del capitale al 27 giu 2016

    • Capitale: GBP 25,100
    SH01

    Cessazione della carica di Giles Stewart Pearson come amministratore in data 26 feb 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Bethan Melges come amministratore in data 26 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Anoop Kang come amministratore in data 26 feb 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    1 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da , Export House Cawsey Way, Woking, Surrey, GU21 6QX a Tempsford Hall Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD in data 16 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2015

    Stato del capitale al 16 lug 2015

    • Capitale: GBP 25,100
    SH01

    Cessazione della carica di Paul Adrian Rayner come amministratore in data 08 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2014

    Stato del capitale al 07 lug 2014

    • Capitale: GBP 25,100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Nicky Cobden come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Paul England come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Stewart Pearson come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOREMAN, Thomas Lee
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Amministratore
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    EnglandBritishDirector221070030001
    MELGES, Bethan Anne Elizabeth
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Amministratore
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    EnglandBritishCompany Secretary199583330002
    COBDEN, Nicky
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    169437970001
    ENGMANN, Catherine
    11 Tudor Way
    SL4 5LT Windsor
    Berkshire
    Segretario
    11 Tudor Way
    SL4 5LT Windsor
    Berkshire
    British92722710004
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Segretario
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    LEE, Kelly
    Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    BritishDeputy Company Secretary138708240001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Segretario
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    PREECE, Richard Alec
    3 Moorings Close
    Parkgate
    CH64 6TL South Wirral
    Segretario
    3 Moorings Close
    Parkgate
    CH64 6TL South Wirral
    British7353920001
    SHAW, Christine Ann
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    161033430001
    SJOGREN, Carl
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    153648560001
    DAVIES, Philip John
    29 Ann Boleyn House
    Queens Reach
    KT8 9DE East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    29 Ann Boleyn House
    Queens Reach
    KT8 9DE East Molesey
    Surrey
    BritishChartered Engineer24640030005
    ELLIS, Christopher John
    5 Alderdale Drive
    High Lane
    SK6 8BX Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    5 Alderdale Drive
    High Lane
    SK6 8BX Stockport
    Cheshire
    BritishPersonnel Manager12943580001
    ENGLAND, Paul David
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector153205540001
    HARRIS, Rodney Hewer
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director104017460001
    HOWITT, Ian Howard
    The Spinney Mill Lane
    Rainhill
    L35 6NG Prescot
    Merseyside
    Amministratore
    The Spinney Mill Lane
    Rainhill
    L35 6NG Prescot
    Merseyside
    EnglandBritishChartered Accountant43712120001
    KANG, Anoop
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Amministratore
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    EnglandBritishDirector198683900001
    LOVELL, Ronald Stanley
    29 Broadway Avenue
    L45 6TB Wallasey
    Merseyside
    Amministratore
    29 Broadway Avenue
    L45 6TB Wallasey
    Merseyside
    BritishComputer Manager12943590001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary36957420004
    PEARSON, Giles Stewart
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    Amministratore
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Great Britain
    United KingdomBritishChartered Accountant180473890001
    PREECE, Richard Alec
    20 Mereworth
    Caldy
    CH48 1QT Wirral
    Amministratore
    20 Mereworth
    Caldy
    CH48 1QT Wirral
    BritishChartered Engineer7353920002
    RAYNER, Paul Adrian
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director45628680002
    TILSTON, David Frank
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director157476100001
    YOUNG, Kevin Andrew
    35 Dean Close
    GU22 8NX Pyrford
    Surrey
    Amministratore
    35 Dean Close
    GU22 8NX Pyrford
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant102706960001

    PARKMAN GROUP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture made between parkman group limited,parkman limited,parkman group professional services limited and parkman property management limited (collectively the "charging subsidiaries") and the royal bank of scotland PLC
    Creato il 12 lug 2000
    Consegnato il 21 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge debenture
    Creato il 12 lug 2000
    Consegnato il 17 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and/or the debenture to the holders of the loan notes issued pursuant to the loan note instrument (as defined therein)
    Brevi particolari
    The property lime kiln close stoke gifford bristol t/n AV205365. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gresham Trust P.L.C as Trustee for Itself and the Holders of the Loan Notes from Time to Time
    Transazioni
    • 17 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 mag 2000
    Consegnato il 02 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a letter dated 24TH may 2000
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee and debenture
    Creato il 14 ago 1981
    Consegnato il 25 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M46). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0