BENCHMARK GROUP LIMITED

BENCHMARK GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBENCHMARK GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00961142
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BENCHMARK GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BENCHMARK GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BENCHMARK GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GECC UK (BGL) LIMITED31 mag 200531 mag 2005
    BENCHMARK GROUP LIMITED02 lug 200402 lug 2004
    BENCHMARK GROUP PLC30 giu 198630 giu 1986
    MANSON FINANCE TRUST PUBLIC LIMITED COMPANY28 ago 196928 ago 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di BENCHMARK GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per BENCHMARK GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 dic 2019

    10 pagineLIQ03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD02

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 28 gen 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 dic 2018

    LRESSP

    Modifica dei dettagli di Ge Capital Corporation (Investment Properties) Limited come persona con controllo significativo il 17 ago 2018

    2 paginePSC05

    legacy

    7 pagineRP04CS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 ott 2018

    • Capitale: GBP 10
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT in data 17 ago 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Zahra Peermohamed come segretario in data 19 lug 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Miss Zahra Peermohamed come segretario in data 01 mar 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stephen Roy Slocombe come segretario in data 28 feb 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stephen Roy Slocombe come amministratore in data 28 feb 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BENCHMARK GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    Segretario
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    British117898690002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    NORMAN, Andrew Peter Livesay
    Little Pitts
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    Segretario
    Little Pitts
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    British76545500001
    PEERMOHAMED, Zahra
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Segretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    243693990001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Segretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    British55097590003
    WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Segretario
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    British85529340001
    WONG, Wing Yooi
    10 Bluebell Close
    SE26 6SN London
    Segretario
    10 Bluebell Close
    SE26 6SN London
    Malaysian1541370001
    ABRAMSON, Christoffer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Amministratore
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Swedish98463110005
    ARCHER, Peter Monahan
    Red Lion House
    Red Lion Hill, The Lee
    HP16 9NF Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Red Lion House
    Red Lion Hill, The Lee
    HP16 9NF Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish65693680001
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Amministratore
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183344960001
    BURGER, Alec
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British And American83634080006
    CORDREY, Peter Graham
    Ockham End Old Lane
    KT11 1NF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Ockham End Old Lane
    KT11 1NF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish14661330001
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Amministratore
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JACOBS, Philip
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish98827150004
    JACOBS, Philip
    8 Spring Grove
    W4 3NH London
    Amministratore
    8 Spring Grove
    W4 3NH London
    United KingdomBritish98827150004
    JEVNE, Anne
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Amministratore
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Norwegian126577610001
    JEVNE, Anne
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Amministratore
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Norwegian106807190001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish202318870001
    KEMPNER, Nigel Justin
    Bix Field
    Bix
    RG9 6BW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bix Field
    Bix
    RG9 6BW Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish170036770001
    KHATTAR, Sat Pal
    3-D Tanglin Hill
    FOREIGN Singapore
    248035
    Singapore
    Amministratore
    3-D Tanglin Hill
    FOREIGN Singapore
    248035
    Singapore
    SingaporeSingaporean75668250002
    KWEK, Leng Hai
    28a Middle Gap Road
    FOREIGN Hong Kong
    Amministratore
    28a Middle Gap Road
    FOREIGN Hong Kong
    Hong KongSingaporean29531280001
    MANCHANDA, Anupam
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United KingdomIndian196338510001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United KingdomBritish183345010001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish139855250001
    MUNTER, Jens Herman Balthazar
    Klampenborg 6a
    FOREIGN Klamenborg 2930
    Denmark
    Amministratore
    Klampenborg 6a
    FOREIGN Klamenborg 2930
    Denmark
    Danish28337740001
    NEWBIGGING, David Kennedy
    15 Old Bailey
    EC4M 7EF London
    Amministratore
    15 Old Bailey
    EC4M 7EF London
    British50153040004
    PALMER, Graham Frederick Boyd
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish170304850001
    PEARSON, William James
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    Amministratore
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    United KingdomBritish133539850001
    QUEK, Chee Hoon
    3 Dalvey Road
    FOREIGN Singapore 259502
    Amministratore
    3 Dalvey Road
    FOREIGN Singapore 259502
    Singapore Citizen59452810001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BENCHMARK GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3958779
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BENCHMARK GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 25 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A subordination agreement dated 15 january 2002 (as defined therein)
    Creato il 15 gen 2002
    Consegnato il 25 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company as an original subordinated creditor under the subordination deed has undertaken to the security trustee that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the subordinated liabilities or the company receives all or any amount in cash or in kind of the subordinated liabilities the company will hold the same upon trust for the security trustee for application in or towards payment of all the senior liabilities and will promptly pay the same to the agent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 25 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 15 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to each finance party under each finance document (all as defined)
    Brevi particolari
    First legal mortgage all shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights; and first fixed charge its interest in all the shares and all related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft,London Branch
    Transazioni
    • 15 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 1999
    Consegnato il 09 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land being 3 st james's square,city of westminster; t/no 168374 with all buildings/fixtures fixed plant machinery thereon; all rights gross rents licence fees and other monies; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination deed
    Creato il 27 lug 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the senior loan agreement dated 27TH july 1999 (as defined)
    Brevi particolari
    Any payment or distribution in cash or kind in respect of or on account of any of the junior liabilities (as defined) and any other benefit thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.,London Branch (The "Senior Creditor")
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 17 nov 1998
    Consegnato il 26 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to each finance party under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    100 ordinary shares of £1 each in benchmark capital limited together with all dividends and interest payable in relation thereto and any rights money pr property accruing by way of bonus redemption option etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 26 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1998
    Consegnato il 09 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First legal mortgage over l/h land being 63 & 64 south molton street in the city of westminster t/n-305210 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery; first .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mar 1998
    Consegnato il 20 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H land being 32 brook street and 65 south molton street in the city of westminster t/no: 341996; f/h land being 11 buckingham gate in the city of westminster t/no: 366496 f/h land being 12 buckingham gate in the city of westminster t/no: 288318 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 29 set 1997
    Consegnato il 01 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due pursuant to the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Floating charge over the company's undertaking property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 1997
    Consegnato il 01 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due pursuant to the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    21 properties the first three of which are 1.f/h land k/a 34 kensington square kensington t/no.LN179272. 2.L/h land k/a 1 derry street kensington t/no. BGL7932 and 3.l/h land k/a 99 to 121 (odd numbers) kensington high street t/no.BGL7915 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery. All gross rents licence fees and other monies receivable, all rights under any contracts or agreements. .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 02 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or the deed or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 49 and 50 poland street and 45 fouberts place W1 t/nos. LN169961, NGL22570 and LN169962 with good l/h (save in the case of NGL22570 which is title absoulute) and all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all rights easements and privileges appurtenant to or benefiting the same. All plant and machinery of the above property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transazioni
    • 02 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 11, 12, 13, 13A, 14&14A grafton street and 164 new bond street london t/n NGL711570 together with all buildings fixtures fitting fixed plant and machinery thereon the benefit of all warranties etc any insurance payable any rental and any other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 4 and 5 preinc's gate knightsbridge westminster london t/n NGL678785 together with all buildings and fixtures fittings fixed plant and machinery thereon the benefit of all warranties etc any insurance payable any rental and all other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1997
    Consegnato il 29 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility agreement (as defined) and/or this deed on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a rivermill (number 151) and rivermill house (number 152) grosvenor road london t/no: NGL360247 and all buildings, fixtures (including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all rights, easements and privileges appurtenant to, or benefiting, the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transazioni
    • 29 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 06 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 06 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A legal charge
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 02 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility agreement dated 3RD october 1996 (as amended by a letter dated 4TH october 1996 and a supplemental agreement dated 23RD december 1996)
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a 99/121 kensington high street and 1 derry street london t/nos: LN179272; BGL7932; BGL7915; NGL391961 and NGL445163 and all buidlings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery, all insurances and all income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transazioni
    • 02 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 02 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility agreement dated 3RD october 1996 (as amended by a letter dated 4TH october 1996 and a supplemental agreement dated 23RD december 1996)
    Brevi particolari
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (Hsbc Property Finance)
    Transazioni
    • 02 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of subordination
    Creato il 10 ago 1987
    Consegnato il 12 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,000.000 and all other monies due or to become due from the company peter metchley holdings limited to the chargee
    Brevi particolari
    Loan of £2,300,000 by the company to peter methley holdings limited and any other loans to them for time to time.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handetsbanker PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BENCHMARK GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 dic 2018Inizio della liquidazione
    30 dic 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0