KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED

KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00966412
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    • lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAMFORD AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED29 nov 199329 nov 1993
    GEO. W. KING (STEVENAGE) LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    KING (T.I.) LIMITED18 nov 196918 nov 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    26 pagineLIQ14

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form LIQ2 - secretary of state's release of liquidator
    4 pagineLIQ MISC

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    17 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    33 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    16 pagineAM02

    Risultato della riunione dei creditori

    6 pagineAM07

    Risultato della riunione dei creditori

    6 pagineAM07

    Indirizzo della sede legale modificato da King Automotive Systems, Chelmarsh, Daimler Green Coventry CV6 3LT a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 06 set 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    57 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Nomina di Stuart David Maddison come amministratore in data 11 mag 2017

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Malcolm Michael Hayes come amministratore in data 11 mag 2017

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sanjay Tiku come amministratore in data 11 mag 2017

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kunal Sabharwal come amministratore in data 11 mag 2017

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anubhav Dham come amministratore in data 11 mag 2017

    2 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 009664120023, creata il 02 mar 2017

    16 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    66 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 set 2016

    • Capitale: GBP 5,000,004
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    40 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 set 2015

    Stato del capitale al 29 set 2015

    • Capitale: GBP 4
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYES, Malcolm Michael
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish138129480001
    MADDISON, Stuart David
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United KingdomBritish233362190001
    BISHOP, Phillipa Lucy
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Segretario
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    British101086280001
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Segretario
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    British63313000002
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Segretario
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    British15235520001
    KERRIGAN, Mark Thomas Farby
    52 Rowlatt Drive
    AL3 4NB St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    52 Rowlatt Drive
    AL3 4NB St Albans
    Hertfordshire
    British7677530002
    MARTIN, Jonathan George
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Segretario
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    190561910001
    PATEL, Ashok Ravjibhai
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    Segretario
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    British150690800001
    PAUL, Peter Michael
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    Segretario
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    British7677600001
    WOTTON, Derek Frank
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Segretario
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    170962680001
    BALL, Roger William
    Bramdean 93 Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HT Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Bramdean 93 Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HT Birmingham
    West Midlands
    British64846000001
    BARRINGER, Terence Ian
    74 High Street
    Clophill
    MK45 4BE Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    74 High Street
    Clophill
    MK45 4BE Bedford
    Bedfordshire
    British7677580001
    BENTON, Derek John
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    EnglandEnglish38163810002
    CHURCHMAN, Richard Alan
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    Amministratore
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    EnglandBritish37813980001
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    United KingdomBritish63313000002
    DHAM, Anubhav
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Amministratore
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    IndiaIndian199368380001
    DHAM, Arvind
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Amministratore
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    IndiaIndian93665890001
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Amministratore
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    British15235520001
    FLINTHAM, John Ernest
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Amministratore
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    United KingdomBritish36461330002
    GREEN, Gareth Edward
    15 Richardson Crescent
    EN7 6WZ West Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Richardson Crescent
    EN7 6WZ West Cheshunt
    Hertfordshire
    British98117470001
    HAUGHTON, Mark James
    11 Jacques Lane
    MK45 4BS Clophill
    Bedfordshire
    Amministratore
    11 Jacques Lane
    MK45 4BS Clophill
    Bedfordshire
    United KingdomBritish98117320001
    JOHNSON, John Michael
    16 Unwin Close
    SG6 3RS Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    16 Unwin Close
    SG6 3RS Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish7677540001
    PARKER, Kenneth
    Chelmarsh
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    Amministratore
    Chelmarsh
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    EnglandBritish83139010002
    PARKER, Kenneth
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    Amministratore
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    EnglandBritish83139010002
    PATEL, Ashok Ravjibhai
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Ltd
    West Midlands
    EnglandBritish36359860001
    PAUL, Peter Michael, Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    British7677600002
    SABHARWAL, Kunal
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    Amministratore
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    IndiaIndian150097480001
    SMITH, Philip Anthony
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    British117160910001
    TIKU, Sanjay
    Chelmarsh
    Daimler
    CV6 3LT Coventry
    Amministratore
    Chelmarsh
    Daimler
    CV6 3LT Coventry
    IndiaIndian150831920001
    TRACEY, Michael
    5 The Old Orchard
    Ebrington
    GL55 6PA Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    5 The Old Orchard
    Ebrington
    GL55 6PA Chipping Campden
    Gloucestershire
    British57624850001
    TULEY, Paul Scott
    2 Salters
    St Michaels Mead
    CM23 4NX Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Salters
    St Michaels Mead
    CM23 4NX Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British98120470001
    WELCH, Roderick Brett
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    Amministratore
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    EnglandBritish90527220001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Freebournes Road
    CM8 3DX Witham
    16
    Essex
    England
    30 giu 2016
    Freebournes Road
    CM8 3DX Witham
    16
    Essex
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09166399
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 mar 2017
    Consegnato il 22 mar 2017
    In corso
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 22 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 ago 2015
    Consegnato il 19 ago 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Us Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 19 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 apr 2015
    Consegnato il 22 apr 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S.Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Security agreement
    Creato il 30 ott 2012
    Consegnato il 12 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Icici Bank UK PLC, Niederlassung Frankfurt Am Main
    Transazioni
    • 12 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of amendment
    Creato il 06 ago 2012
    Consegnato il 10 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Idbi Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 lug 2011
    Consegnato il 11 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Idbi Bank Limited, Difc Branch, Dubai
    Transazioni
    • 11 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 18 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Account number 03093263. sort code 20 00 00. account name bb re king automotive systems limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Company Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 mar 2009
    Consegnato il 04 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Amtek Investments (UK) Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 16 nov 2005
    Consegnato il 26 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items being plant no 1238 p j hare twin shock absorber assembly machine atlas copco tensor S7 control s/n 98X0049X200 assy, plant no 1237 p j hare twin shock absorber assembly machine atlas copco tensor S7 control s/n 98X0050X200 assy and plant no 6035 guyson orbit 800 parts washer s/n 50105 bentley assy for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC C/O Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 26 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 07 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 07 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 29 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facilities agreement and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    Land to the southeast of capmartin road, radford, west midlands title number wm 588798.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    Land to the south east of capmartin road, redford, west midlands title number WM588798.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage as defined therein
    Brevi particolari
    The chattels set out on the schedule attached to the form M395 together with any part or parts thereof and all additions alternatives accessories replacements and renewals of component parts thereto and all technical records and log books thereof together with any item or items, the insurance policies and the contracts being the right and title and interest in and to the benefit of all present and future agreements relating to the chattels.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facilities agreement and the chattel mortgage as defined therein
    Brevi particolari
    The chattels set out on the schedule attached to the form M395 together with any part or parts thereof and all additions alternatives accessories replacements and renewals of component parts thereto and all technical records and log books thereof together with any item or items, the insurance policies and the contracts being the right and title and interest in and to the benefit of all present and future agreements relating to the chattels.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the loan (as defined) pursuant to a deed of guaranty and indemnity of even date
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC, for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 feb 1982
    Consegnato il 23 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee debenture
    Creato il 10 feb 1982
    Consegnato il 19 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1982Registrazione di un'ipoteca

    KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 lug 2017Inizio dell'amministrazione
    26 lug 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Matthew Boyd Callaghan
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    2
    DataTipo
    26 lug 2018Inizio della liquidazione
    27 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Matthew Boyd Callaghan
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0