COUTTS GROUP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUTTS GROUP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00966434
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUTTS GROUP?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova COUTTS GROUP?

    Indirizzo della sede legale
    1 Princes Street
    EC2R 8PB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUTTS GROUP?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILLIAMS, GLYN & CO.18 nov 196918 nov 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUTTS GROUP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per COUTTS GROUP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Notifica di Natwest Markets Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    9 pagineAA

    Nomina di Gary Moore come amministratore in data 01 giu 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew James Nicholson come amministratore in data 31 mag 2018

    1 pagineTM01

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016

    9 pagineAAMD

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016

    9 pagineAAMD

    Nomina di Yvonne Addison come amministratore in data 28 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Carolyn Jean Down come amministratore in data 28 feb 2018

    1 pagineTM01

    Notifica di The Royal Bank of Scotland Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 set 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 set 2015

    Stato del capitale al 18 set 2015

    • Capitale: GBP 2,500,000
    SH01

    Nomina di Mrs Carolyn Jean Down come amministratore in data 18 giu 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 set 2014

    Stato del capitale al 23 set 2014

    • Capitale: GBP 2,500,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    9 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 set 2013

    Stato del capitale al 19 set 2013

    • Capitale: GBP 2,500,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di COUTTS GROUP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Segretario
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830001
    ADDISON, Yvonne
    Rbs Gogarburn
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    175
    Scotland
    Amministratore
    Rbs Gogarburn
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    175
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official168780540002
    MOORE, Gary
    Business House G, PO BOX 1000
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Amministratore
    Business House G, PO BOX 1000
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    ScotlandBritishBank Official247794910001
    SUTHERLAND, Sally Jane
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official166757310001
    DOYLE, Sally Anne
    68 Maple Road
    Penge
    SE20 8HE London
    Segretario
    68 Maple Road
    Penge
    SE20 8HE London
    British67985470001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Segretario
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    BritishBank Official1369400003
    RUSSELL, Christine Anne
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    164015060001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Amministratore
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    BritishAsst Co Secretary62801910001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Amministratore
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    BritishAsst Co Secretary62801910001
    DARE, Simon Christopher
    6 Bishops Road
    Upper Hale
    GU9 0JA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    6 Bishops Road
    Upper Hale
    GU9 0JA Farnham
    Surrey
    BritishBank Official53439560001
    DOWN, Carolyn Jean
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Amministratore
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    EnglandBritishSenior Co. Sec. Asst.184298970001
    DOYLE, Sally Anne
    68 Maple Road
    Penge
    SE20 8HE London
    Amministratore
    68 Maple Road
    Penge
    SE20 8HE London
    EnglandBritishBanker67985470001
    HARRIS, Roy John
    24 Beech Road
    Wythall
    B47 5QS Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    24 Beech Road
    Wythall
    B47 5QS Birmingham
    West Midlands
    BritishBank Manager6828890001
    HOPKINS, Richard James
    27 Temple Avenue
    Shirley
    CR0 8QE Croydon
    Amministratore
    27 Temple Avenue
    Shirley
    CR0 8QE Croydon
    BritishBank Official92378040001
    JACKSON, James Anthony
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London,
    280
    England
    EnglandBritishBank Official154943750001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Amministratore
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    BritishBank Official1369400003
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Amministratore
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    EnglandBritishChartered Secretary34423910002
    MACARTHUR, Neil Clark
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    United KingdomBritishBank Official81529340002
    MILLER, John Thomas Henry
    49 Barnton Park Avenue
    EH4 6HD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    49 Barnton Park Avenue
    EH4 6HD Edinburgh
    Midlothian
    BritishManager802080001
    MORIARTY, Antoinette Una
    555 Rayners Lane
    HA5 5HP Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    555 Rayners Lane
    HA5 5HP Pinner
    Middlesex
    BritishBank Official54206370002
    NICHOLSON, Andrew James
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official163664680002
    SMITH, Carolyn
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    Amministratore
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    BritishBank Official68031820001
    STEWART, Gary Robert Mcneilly
    Burnbrae Avenue
    EH12 8AU Edinburgh
    10
    Scotland
    Amministratore
    Burnbrae Avenue
    EH12 8AU Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritishBanker128173150002
    STRUGNELL, Penelope Ann
    19 Dewpond Walk
    Lychpit
    RG24 8RZ Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    19 Dewpond Walk
    Lychpit
    RG24 8RZ Basingstoke
    Hampshire
    BritishBank Officer17036860001
    THOMPSON, Kenneth
    19 (2f2) India Street
    EH3 6HE Edinburgh
    Amministratore
    19 (2f2) India Street
    EH3 6HE Edinburgh
    BritishDirector/Charactered Accountant239570002
    TROTT, Helen Clare
    19 Pine Grove
    SW19 7HD Wimbledon
    Amministratore
    19 Pine Grove
    SW19 7HD Wimbledon
    BritishSolicitor102160940003
    WALLACE, Barbara Charlotte
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Amministratore
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official150055310001
    WHITEHEAD, Grahame Taylor
    Southlea 20 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Amministratore
    Southlea 20 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    BritishBank Official1363570003

    Chi sono le persone con controllo significativo di COUTTS GROUP?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Royal Bank Of Scotland Plc
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    06 apr 2016
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1948
    Luogo di registrazioneRegister Of Members
    Numero di registrazioneSc090312
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Natwest Markets Plc
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    06 apr 2016
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1948
    Luogo di registrazioneCompanies House Scotland
    Numero di registrazioneSc090312
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    COUTTS GROUP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge and security trust deed
    Creato il 29 lug 1993
    Consegnato il 10 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in clause 5 of the balc sale agreement and the covenant contained in clause 6(c) of the charge and security trust deed
    Brevi particolari
    First fixed legal charge the balc and all the company's rights attaching or relating thereto together with any cash delivered by the company pursuant to clause 2(b) of the charge and pending payment pursuant to clause 3(d) and clause 3(e) thereof, any monies received by the custodian on redemption or repayment of the bonds to the extent that such monies are payable under clause 5 of the balc sale agreement.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 10 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and security trust deed
    Creato il 12 mar 1993
    Consegnato il 15 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing the payment and discharge of the company's undertakings contained in clause 5(a) and (b) of the balc sale agreement and the covenant contained in clause 6(c) of the charge and security due to the law debenture trust corporation PLC.
    Brevi particolari
    By way of first legal charge,all tha company's rights ataching or relating to balc.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge and security trust deed
    Creato il 24 nov 1992
    Consegnato il 04 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in clause 5 of the balc sale agreement and the covenant contained in clause 6(c) of the charge and security trust deed
    Brevi particolari
    All the rights.......pursuant to clause 2(b) of the charge....any monies received by the custodian or redemption of the bonds......see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 04 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and security trust deed
    Creato il 09 lug 1992
    Consegnato il 23 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the balc sale agreement and the charge and security trust deed
    Brevi particolari
    All the company's rights attaching or relating to the balc sale agreement (see form 395 and attached schedules for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0