COUTTS GROUP
Panoramica
Nome della società | COUTTS GROUP |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
Numero di società | 00966434 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUTTS GROUP?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova COUTTS GROUP?
Indirizzo della sede legale | 1 Princes Street EC2R 8PB London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COUTTS GROUP?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WILLIAMS, GLYN & CO. | 18 nov 1969 | 18 nov 1969 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUTTS GROUP?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per COUTTS GROUP?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Notifica di Natwest Markets Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Gary Moore come amministratore in data 01 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew James Nicholson come amministratore in data 31 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016 | 9 pagine | AAMD | ||||||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016 | 9 pagine | AAMD | ||||||||||
Nomina di Yvonne Addison come amministratore in data 28 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carolyn Jean Down come amministratore in data 28 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica di The Royal Bank of Scotland Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 set 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mrs Carolyn Jean Down come amministratore in data 18 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 9 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUTTS GROUP?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
ADDISON, Yvonne | Amministratore | Rbs Gogarburn Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh 175 Scotland | Scotland | British | Bank Official | 168780540002 | ||||||||
MOORE, Gary | Amministratore | Business House G, PO BOX 1000 EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn | Scotland | British | Bank Official | 247794910001 | ||||||||
SUTHERLAND, Sally Jane | Amministratore | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | Bank Official | 166757310001 | ||||||||
DOYLE, Sally Anne | Segretario | 68 Maple Road Penge SE20 8HE London | British | 67985470001 | ||||||||||
LEA, John Albert | Segretario | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | Bank Official | 1369400003 | |||||||||
RUSSELL, Christine Anne | Segretario | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 164015060001 | |||||||||||
WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
CUNNINGHAM, Angela Mary | Amministratore | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | Asst Co Secretary | 62801910001 | |||||||||
CUNNINGHAM, Angela Mary | Amministratore | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | Asst Co Secretary | 62801910001 | |||||||||
DARE, Simon Christopher | Amministratore | 6 Bishops Road Upper Hale GU9 0JA Farnham Surrey | British | Bank Official | 53439560001 | |||||||||
DOWN, Carolyn Jean | Amministratore | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | England | British | Senior Co. Sec. Asst. | 184298970001 | ||||||||
DOYLE, Sally Anne | Amministratore | 68 Maple Road Penge SE20 8HE London | England | British | Banker | 67985470001 | ||||||||
HARRIS, Roy John | Amministratore | 24 Beech Road Wythall B47 5QS Birmingham West Midlands | British | Bank Manager | 6828890001 | |||||||||
HOPKINS, Richard James | Amministratore | 27 Temple Avenue Shirley CR0 8QE Croydon | British | Bank Official | 92378040001 | |||||||||
JACKSON, James Anthony | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | England | British | Bank Official | 154943750001 | ||||||||
LEA, John Albert | Amministratore | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | Bank Official | 1369400003 | |||||||||
LEWIS, Derek John | Amministratore | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | England | British | Chartered Secretary | 34423910002 | ||||||||
MACARTHUR, Neil Clark | Amministratore | Rbs Gogarburn EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | United Kingdom | British | Bank Official | 81529340002 | ||||||||
MILLER, John Thomas Henry | Amministratore | 49 Barnton Park Avenue EH4 6HD Edinburgh Midlothian | British | Manager | 802080001 | |||||||||
MORIARTY, Antoinette Una | Amministratore | 555 Rayners Lane HA5 5HP Pinner Middlesex | British | Bank Official | 54206370002 | |||||||||
NICHOLSON, Andrew James | Amministratore | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | Bank Official | 163664680002 | ||||||||
SMITH, Carolyn | Amministratore | 9 Bedford Court Mowbray Road Upper Norwood SE19 2RW London | British | Bank Official | 68031820001 | |||||||||
STEWART, Gary Robert Mcneilly | Amministratore | Burnbrae Avenue EH12 8AU Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | Banker | 128173150002 | ||||||||
STRUGNELL, Penelope Ann | Amministratore | 19 Dewpond Walk Lychpit RG24 8RZ Basingstoke Hampshire | British | Bank Officer | 17036860001 | |||||||||
THOMPSON, Kenneth | Amministratore | 19 (2f2) India Street EH3 6HE Edinburgh | British | Director/Charactered Accountant | 239570002 | |||||||||
TROTT, Helen Clare | Amministratore | 19 Pine Grove SW19 7HD Wimbledon | British | Solicitor | 102160940003 | |||||||||
WALLACE, Barbara Charlotte | Amministratore | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | Bank Official | 150055310001 | ||||||||
WHITEHEAD, Grahame Taylor | Amministratore | Southlea 20 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | Bank Official | 1363570003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COUTTS GROUP?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 apr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Natwest Markets Plc | 06 apr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
COUTTS GROUP ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge and security trust deed | Creato il 29 lug 1993 Consegnato il 10 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in clause 5 of the balc sale agreement and the covenant contained in clause 6(c) of the charge and security trust deed | |
Brevi particolari First fixed legal charge the balc and all the company's rights attaching or relating thereto together with any cash delivered by the company pursuant to clause 2(b) of the charge and pending payment pursuant to clause 3(d) and clause 3(e) thereof, any monies received by the custodian on redemption or repayment of the bonds to the extent that such monies are payable under clause 5 of the balc sale agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge and security trust deed | Creato il 12 mar 1993 Consegnato il 15 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing the payment and discharge of the company's undertakings contained in clause 5(a) and (b) of the balc sale agreement and the covenant contained in clause 6(c) of the charge and security due to the law debenture trust corporation PLC. | |
Brevi particolari By way of first legal charge,all tha company's rights ataching or relating to balc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge and security trust deed | Creato il 24 nov 1992 Consegnato il 04 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in clause 5 of the balc sale agreement and the covenant contained in clause 6(c) of the charge and security trust deed | |
Brevi particolari All the rights.......pursuant to clause 2(b) of the charge....any monies received by the custodian or redemption of the bonds......see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge and security trust deed | Creato il 09 lug 1992 Consegnato il 23 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the balc sale agreement and the charge and security trust deed | |
Brevi particolari All the company's rights attaching or relating to the balc sale agreement (see form 395 and attached schedules for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0