HEWDEN TOWER CRANES LIMITED

HEWDEN TOWER CRANES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEWDEN TOWER CRANES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00967197
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Trafford House Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RL Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEWDEN STUART WOLFF LIMITED10 apr 198910 apr 1989
    WOLFF DAVIES TOWER CRANES LIMITED02 mar 198202 mar 1982
    STANLEY DAVIES TOWER CRANES LIMITED28 nov 196928 nov 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin Parkes il 28 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Susan Shardlow il 28 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Susan Shardlow il 28 giu 2010

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Finning Uk Ltd Watling Street Cannock Staffordshire WS11 8LL in data 02 giu 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Susan Shardlow come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Douglas Sprout come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Douglas Sprout come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HEWDEN TOWER CRANES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHARDLOW, Susan
    Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    Segretario
    Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    British151298920001
    PARKES, Kevin
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United Kingdom
    Amministratore
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector146059290002
    SHARDLOW, Susan
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United Kingdom
    Amministratore
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director151325710002
    DEAKIN, Alastair Wright
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    Segretario
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    British63127160001
    NETHERWAY, Robert William
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Segretario
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    BritishDirector30995760008
    SPROUT, Douglas
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    England
    Segretario
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    England
    British149542170001
    APPLEYARD, Sydney
    38 Hunt Street
    Lock Lane
    WF10 2LB Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    38 Hunt Street
    Lock Lane
    WF10 2LB Castleford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director58265390001
    DAVIES, Michael
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Amministratore
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director140297230001
    DICKINSON, Neil Robert
    C/O Finning (Uk) Ltd.
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    C/O Finning (Uk) Ltd.
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director102224030002
    FINDLAY, Alexander Fraser
    Pitfour 1 Leewood Park
    FK15 0NX Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Pitfour 1 Leewood Park
    FK15 0NX Dunblane
    Perthshire
    BritishCompany Director634480001
    GOODWIN, Matthew Dean, Sir
    87 Kelvin Court
    G12 0AH Glasgow
    Amministratore
    87 Kelvin Court
    G12 0AH Glasgow
    ScotlandBritishCh56200004
    HOTCHKISS, Colin Archibald
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Amministratore
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    CanadianCompany Director133634850001
    JARVIS, Paul James Christopher
    49 Oatlands Avenue
    KT13 9SS Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    49 Oatlands Avenue
    KT13 9SS Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer2293800001
    LEDGER, Raymond Henry
    4 Brunswick House 5/6 West Park
    HG1 1BL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Brunswick House 5/6 West Park
    HG1 1BL Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director59499280002
    LLOYD, Nicholas Bradley
    Hewden, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Amministratore
    Hewden, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    BritishManaging Director91982390004
    NAPIER, Alistair George St Clair
    33/13 Murrayfield Road
    EH12 6EP Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    33/13 Murrayfield Road
    EH12 6EP Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director57915070001
    NETHERWAY, Robert William
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Amministratore
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    United KingdomBritishDirector30995760008
    PHILLIPS, Paul Edward
    2 Waterloo Close
    Abbotsley
    PE19 6UX Sy Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Waterloo Close
    Abbotsley
    PE19 6UX Sy Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director254589770001
    QUENBY, Roger Brian
    1 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    1 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritishDirector636400001
    SHERLOCK, Brian Foster
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Amministratore
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    BritishCompany Director107903020002
    SPROUT, Douglas
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomCanadianCompany Director149547490001
    STUART, Ronald Grierson
    17 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    Amministratore
    17 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    BritishCompany Director612540001
    STUDD, Michael Keith
    Honeycutt
    Old Great North Road
    WF8 3BL Barrington
    Yorkshire
    Amministratore
    Honeycutt
    Old Great North Road
    WF8 3BL Barrington
    Yorkshire
    BritishCompany Director15277910001

    HEWDEN TOWER CRANES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of offset
    Creato il 28 ago 1999
    Consegnato il 15 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or the other companies named therein
    Brevi particolari
    The total of the amounts from time to time at the credit of all accounts held with the bank in the name of the granter.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Letter of off set
    Creato il 07 dic 1990
    Consegnato il 27 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1970
    Consegnato il 20 gen 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000
    Brevi particolari
    Plant & machinery for details of which see schedule attached to doc. 12.
    Persone aventi diritto
    • General Guarantee Corporation (Northern) LTD
    Transazioni
    • 20 gen 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 16 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0