QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00969962 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Essex England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TAYLOR WILLIAMS DEVELOPMENTS LIMITED | 21 ott 1987 | 21 ott 1987 |
SECKLOW INVESTMENTS LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE a Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 07 dic 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sally Ann Coughlan il 02 ott 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex. RM1 3NG a 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 29 set 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Martin Quinn come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Rosenberg come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Erwin Rieck come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di W2001 Britannia Llc come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di W2001 Two Cv come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Erwin Joseph Rieck il 12 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di W2001 Britannia Llc come amministratore | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di W2001 Two Cv come amministratore | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Veronique Menard come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUGHLAN, Sally Ann | Segretario | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Suite 64 Essex England | British | 107832420001 | ||||||||||||
QUINN, Martin Joseph | Amministratore | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | Asset Manager | 186571310001 | ||||||||||
BURGESS, Keith John | Segretario | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | Company Director | 7009790002 | |||||||||||
CHRISTIAN, Tracy Joanne | Segretario | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||||||||
JONES, Vanessa | Segretario | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||||||||
NOBLE, Martin Geoffrey Harold | Segretario | 5 Sillswood MK46 5PL Olney Buckinghamshire | British | 11913310002 | ||||||||||||
PURVIS, Martin Terence Alan | Segretario | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||||||||
STADEN, Paul Sidney | Segretario | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | Company Director | 35453800001 | |||||||||||
WATERS, Jonathan Roy | Segretario | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||||||||
ALLSOP, Heather Louise | Amministratore | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | Investment Banker | 101912850001 | |||||||||||
BEASLEY, Colin John | Amministratore | The Ridings Plumpton Road, Woodend NN12 8RZ Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 65499270001 | ||||||||||
CAIRNS, Michael Anthony | Amministratore | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Director | 36488470001 | ||||||||||
COLES, Alan Clifford | Amministratore | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | Chartered Accountant | 101144900002 | ||||||||||
COLLYER, Brian Charles | Amministratore | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | Investment Banker | 101144260001 | |||||||||||
COPPEL, Andrew Maxwell | Amministratore | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | Group Chief Executive | 14330100002 | ||||||||||
CUTTS, John Charles | Amministratore | Tudor Gables Old Warwick Road Lapworth B94 6AY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 56651680001 | ||||||||||
GOIN, Russell Todd | Amministratore | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | Banker | 108675490001 | |||||||||||
KABALAN, Fadi | Amministratore | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | Chartered Accountant | 133846470001 | ||||||||||
KRAIS, Ashley Simon | Amministratore | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | Company Director | 105921220001 | ||||||||||
LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Amministratore | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Company Director | 4958800007 | ||||||||||
MENARD, Veronique Pascale Dominique | Amministratore | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | Banker | 141156250001 | ||||||||||
METCALFE, Michael Stuart | Amministratore | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Company Director | 40294180002 | ||||||||||
MOORE, Richard John | Amministratore | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | Company Director | 101144680001 | ||||||||||
MULAHASANI, Heather Louise | Amministratore | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | Banker | 136994090001 | ||||||||||
O'SHEA, Michael Patrick | Amministratore | Behihane Leckhamstead Road Wicken MK19 6BY Milton Keynes Buckinghamshire | British | Property Developer | 35170010001 | |||||||||||
OGDEN, Kathryn | Amministratore | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | Analyst | 114248790002 | |||||||||||
RIECK, Erwin Joseph | Amministratore | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | Chief Executive Officer | 108675520002 | |||||||||||
ROSENBERG, Matthew Alexander | Amministratore | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | England | British | Asset Manager | 134723670001 | ||||||||||
SCOBLE, Timothy James | Amministratore | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 83743120001 | ||||||||||
STADEN, Paul Sidney | Amministratore | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | Chartered Accountant | 35453800001 | |||||||||||
WILLIAMS, Graham Glyn | Amministratore | Fairfield High Street Harpole NN7 4BS Northampton Northamptonshire | British | Chartered Surveyor | 12368700001 | |||||||||||
WILLIAMS, John Taylor | Amministratore | Wappenham Manor Wappenham NN12 8SH Towcester Northamptonshire | British | Property Developer | 35538260001 | |||||||||||
W2001 BRITANNIA LLC | Amministratore | The Corporation Trust Company 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Company County Of Newcastle Usa |
| 152068420001 | ||||||||||||
W2001 TWO CV | Amministratore | Strawinskylaan 1207 1077 Xx Amsterdam Strawinskylaan 1207 Netherlands |
| 152068160001 |
QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A composite guarantee and debenture | Creato il 23 feb 2005 Consegnato il 04 mar 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 24 nov 2004 Consegnato il 14 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 giu 2004 Consegnato il 25 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Creato il 08 giu 2004 Consegnato il 11 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 25 mar 2004 Consegnato il 26 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 lug 1980 Consegnato il 16 lug 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H:- 7, market square, stony stratford, milton keynes, bucks. As in a conveyance dated 9.3.79. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 gen 1980 Consegnato il 23 gen 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land on south east side of st. James mill road, northamptonshire & factory premises erected thereon. Title no:- nn 31115. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 gen 1980 Consegnato il 23 gen 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H:- 8, market square, stoney stratford, milton keynes, bucks, described in a conveyance dated 9.3.79. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 mag 1979 Consegnato il 14 giu 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land lying to the S.W. of sundon park road, luton beds. Title no:- bd 40444. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0