TWILIGHT BAND LIMITED

TWILIGHT BAND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTWILIGHT BAND LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00973272
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TWILIGHT BAND LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TWILIGHT BAND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TWILIGHT BAND LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAX ARC LIMITED19 set 198619 set 1986
    MERRYCHEF LIMITED25 feb 197025 feb 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di TWILIGHT BAND LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per TWILIGHT BAND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Stato del capitale al 10 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    legacy

    2 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled 26/04/2013
    RES13

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 08 mag 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di TWILIGHT BAND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    JELLY, Jennifer
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British1745390001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    AIREY, Andrew Robert
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    EnglandBritish54515590004
    BARKER, Simon Charles
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    British113730600001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BRAY, Kenneth Ivor
    Nether Hall
    Main Street, Denton
    NG32 1JR Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Nether Hall
    Main Street, Denton
    NG32 1JR Grantham
    Lincolnshire
    British45153770002
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GEORGE, Alan
    Oak Tree Cottage Robin Hood Lane
    Sutton Green
    GU4 7QG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Oak Tree Cottage Robin Hood Lane
    Sutton Green
    GU4 7QG Guildford
    Surrey
    British1745400001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    HOUGHTON, Reece
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    British27953100001
    JELLY, Aubrey Bruce, Mr.
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    Amministratore
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    United KingdomBritish82764370003
    JELLY, Jennifer
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British1745390001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    TONER, Robert Anthony
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish70516300002
    WHITELING, Mark Argent
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish101297630001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    TWILIGHT BAND LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 26 gen 1983
    Consegnato il 11 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof including fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 11 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed
    Creato il 26 gen 1983
    Consegnato il 11 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £50,000 due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 19/8/1977
    Brevi particolari
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Ford & Weston Holdings Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 10 dic 1982
    Consegnato il 31 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 mar 1981
    Consegnato il 10 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures fixed plant & machinery. (See doc M27).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0