DAVID CONRAD (SALES) LIMITED

DAVID CONRAD (SALES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAVID CONRAD (SALES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00975554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAVID CONRAD (SALES) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DAVID CONRAD (SALES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAVID CONRAD (SALES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DAVID CONRAD (SALES) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DAVID CONRAD (SALES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 nov 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 10 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2015

    Stato del capitale al 11 giu 2015

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2014

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Scott Richard Mccabe come amministratore in data 19 ago 2014

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sheffield United Fc Bramall Lane Sheffield Yorkshire S2 4SU a Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ in data 19 ago 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Malachy Brannigan come amministratore in data 19 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Malachy Brannigan come amministratore in data 08 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Burns come amministratore in data 08 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2014

    Stato del capitale al 19 giu 2014

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    Nomina di Esplanade Director Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Craig Burns come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Esplanade Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Craig Burns come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Julian Winter come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Craig Burns come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di DAVID CONRAD (SALES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish151895310001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6133267
    123430390001
    BURNS, Craig
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Segretario
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    167993930001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Segretario
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    British118147580002
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Segretario
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    153054090001
    LIGHTBURN, Trevor
    75 Grosvenor Avenue
    Hartford
    CW8 1RP Northwich
    Cheshire
    Segretario
    75 Grosvenor Avenue
    Hartford
    CW8 1RP Northwich
    Cheshire
    British27731500001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Segretario
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    WHETTON, Barry Newton
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    Segretario
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    British14277000002
    BAMFORD, Alan Maxwell
    53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GY Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GY Sheffield
    South Yorkshire
    British82114720001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2883500001
    BIRCH, Trevor
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Amministratore
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    UkBritish160667800001
    BRANNIGAN, Malachy
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandIrish110939170001
    BURNS, Craig
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish167991320001
    CAPPER, David
    5 Wychwood Glen
    Sothall
    S20 2QL Sheffield
    Amministratore
    5 Wychwood Glen
    Sothall
    S20 2QL Sheffield
    British61833820001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Amministratore
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    EDELSON, John Michael
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    Amministratore
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    EnglandBritish28353840001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    GREEN, Charles Alexander
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    British75952680002
    HARROP, David Anthony
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    HAWTHORNE, Philip
    11 Avondale Road
    Swinley
    WN1 2BE Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    11 Avondale Road
    Swinley
    WN1 2BE Wigan
    Lancashire
    British79740350001
    LYONS, Jonathan Howard
    The Gables
    Rossmill Lane
    WA15 0AH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    The Gables
    Rossmill Lane
    WA15 0AH Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12396450001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Amministratore
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Amministratore
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MCDONALD, Anthony Michael
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    British51141710003
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    Amministratore
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Amministratore
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    THURMAN, John Lythall
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    British41580370003
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    Amministratore
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritish26617400002
    WHETTON, Barry Newton
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    Amministratore
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    British14277000002
    WINTER, Julian
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WOOD, Peter Philip
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    British59507480001

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 29 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Argent Credit Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group cross guarantee industry and debenture.
    Creato il 19 dic 1990
    Consegnato il 04 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
    Transazioni
    • 04 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 27 lug 1990
    Consegnato il 08 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 dic 1981
    Consegnato il 18 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge over all book & other debts and fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts except above uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1981Registrazione di un'ipoteca

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 nov 2015Inizio della liquidazione
    17 ago 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0