REDHALL ENERGY LIMITED

REDHALL ENERGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREDHALL ENERGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00977940
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REDHALL ENERGY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REDHALL ENERGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REDHALL ENERGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATTW. T. SHAW STEELWORK LIMITED30 ago 198830 ago 1988
    MATTW. T. SHAW (STEELWORK) LIMITED24 apr 197024 apr 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di REDHALL ENERGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per REDHALL ENERGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA England a 4 Hardman Square Manchester M3 3EB in data 18 set 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione delle attività

    6 pagineLIQ02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 05 set 2019

    LRESEX

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Russell David Haworth il 10 gen 2019

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Wayne Pearson come amministratore in data 03 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Russell David Haworth come amministratore in data 03 nov 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Philip Comer il 09 ago 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Christopher John Kelly come segretario in data 01 lug 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Simon Philip Comer come segretario in data 02 lug 2018

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Simon Philip Comer come amministratore in data 02 lug 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher John Kelly come amministratore in data 29 giu 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Brierley come amministratore in data 31 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Wayne Pearson come amministratore in data 19 mar 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN a C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA in data 05 ago 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ott 2015

    Stato del capitale al 19 ott 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di REDHALL ENERGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COMER, Simon Philip
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Segretario
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    248227690001
    COMER, Simon Philip
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritishDirector206088760003
    HAWORTH, Russell David
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritishDirector201533400002
    BOOTH, Anthony Miles Philip
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant32499750001
    ENTWISTLE, Alan John
    4 Moorlands View
    BL3 3TN Bolton
    Lancashire
    Segretario
    4 Moorlands View
    BL3 3TN Bolton
    Lancashire
    British2079060001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187645860001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector94645950001
    ROBSON, William
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    Segretario
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    BritishCompany Director74793730002
    BOOTH, Anthony Miles Philip
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director32499750001
    BOOTH, James Gerrard
    Forest Side
    Lostock Junction Lane
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Forest Side
    Lostock Junction Lane
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    BritishStructural Engineer2079070001
    BOOTH, Robert Leyland
    24 Lostock Junction Lane
    Lostock
    BL6 4JR Bolton
    Amministratore
    24 Lostock Junction Lane
    Lostock
    BL6 4JR Bolton
    BritishEngineer41595700001
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishChief Executive54808010002
    CHILTON, Keith
    Willow Cottage Barrow Lane
    Swarkestone
    DE73 1JA Derby
    Amministratore
    Willow Cottage Barrow Lane
    Swarkestone
    DE73 1JA Derby
    BritishCompany Director52051390001
    COLEMAN, David
    73 Firs Road
    BL5 1EZ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    73 Firs Road
    BL5 1EZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant52948340001
    ELCOMBE, Brian Thomas
    205 Lunedale Road
    DA2 6HU Dartford
    Kent
    Amministratore
    205 Lunedale Road
    DA2 6HU Dartford
    Kent
    BritishDirector19509250001
    FOSTER, Robert Simon
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    Amministratore
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector134973970001
    HARVEY, Leslie
    7 Overdene Close
    Lostock
    BL6 4DY Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    7 Overdene Close
    Lostock
    BL6 4DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCommercial Director17503690001
    JORDAN, Roy Gregory
    15 Monroe Close
    LE16 7QN Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    15 Monroe Close
    LE16 7QN Market Harborough
    Leicestershire
    UsaCompany Director52042650002
    JURY, Stuart Norman
    39 Little Hill
    Heronsgate
    WD3 5BX Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 Little Hill
    Heronsgate
    WD3 5BX Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishStructural Engineer19504530001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director188444350001
    LEPINE, Ronald
    10 Morden Street
    SE13 7QX London
    Amministratore
    10 Morden Street
    SE13 7QX London
    BritishContracts Director37816190001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director94645950001
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    England
    United KingdomIrishDirector106172200001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector212154420001
    ROBSON, William
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    Amministratore
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    BritishCompany Director74793730002
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector58727820002

    Chi sono le persone con controllo significativo di REDHALL ENERGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 apr 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione263995
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    REDHALL ENERGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13/02/01 (the agreement)
    Creato il 16 nov 2004
    Consegnato il 18 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13 february 2001
    Creato il 24 ago 2004
    Consegnato il 14 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 13 feb 2001
    Consegnato il 17 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 ago 1998
    Consegnato il 27 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 19 set 1996
    Consegnato il 01 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 mag 1988
    Consegnato il 10 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 giu 1987
    Consegnato il 03 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 08 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 nov 1981
    Consegnato il 16 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 08 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    REDHALL ENERGY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 set 2019Inizio della liquidazione
    22 dic 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah O'Toole
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Christopher Petts
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0