KELNIGAL GROUP LIMITED

KELNIGAL GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKELNIGAL GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00979170
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KELNIGAL GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    200 Great Dover Street
    SE1 4YB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGH-POINT RENDEL GROUP LIMITED26 feb 200726 feb 2007
    HIGH-POINT RENDEL GROUP PLC14 gen 199814 gen 1998
    HIGH-POINT PLC06 ott 198806 ott 1988
    HIGH-POINT SERVICES GROUP PLC31 dic 197731 dic 1977
    HIGH-POINT CONTRACT SERVICES LIMITED08 mag 197008 mag 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2016 al 30 set 2016

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da 61 Southwark Street London SE1 1SA a 200 Great Dover Street London SE1 4YB in data 06 lug 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 gen 2016

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced. Approval & authorisation of reduction 07/12/2015
    RES13

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    16 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed high-point rendel group LIMITED\certificate issued on 04/08/15
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 02 lug 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Soddisfazione dell'onere 009791700014 in pieno

    6 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2015

    Stato del capitale al 12 gen 2015

    • Capitale: GBP 274,249.12
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    17 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 19 apr 2014 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 19 apr 2013

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 dic 2013

    Stato del capitale al 06 dic 2013

    • Capitale: GBP 274,249.12
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2013 al 19 apr 2013

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 009791700014

    191 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 lug 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARSONS, Charlotte Louise
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Segretario
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Other135626530001
    BELL, Nigel Stuart
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Amministratore
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritish91913690001
    HINGLEY, Kelvin William Thomas
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Amministratore
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritish50467220002
    PARSONS, Charlotte Louise
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Amministratore
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritish140414820004
    BEST, John David
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    British2810080001
    DAVISON, Suzanne
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    Segretario
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    British80856470001
    DESMOND, Pat
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    Segretario
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    British52839700001
    DIXON, Leslie Albert
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    Segretario
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    British3640870001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Segretario
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Segretario
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Segretario
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    British12317760001
    BENNETT, Melvin Eugene
    2016 Bulrush Lane
    Cardiff By The Sea
    FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa
    Amministratore
    2016 Bulrush Lane
    Cardiff By The Sea
    FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa
    American43502520002
    DESMOND, Pat
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    Amministratore
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    British52839700001
    DIXON, Leslie Albert
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    British3640870001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Amministratore
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    HOOKWAY, David Wilfred
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    Amministratore
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    British374710001
    JOHNSON, Peter
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    British11342310001
    PALMER, Horace Anthony
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish45646020002
    PERREY, Derek Randall
    Oaklands Rockbear Hill
    Marsh Green
    EX5 2EZ Exeter
    Amministratore
    Oaklands Rockbear Hill
    Marsh Green
    EX5 2EZ Exeter
    British12614160001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    SHEPPARD, Allen John George, The Right Honourable Lord
    Didgmere Hall Low Hill Road
    Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Amministratore
    Didgmere Hall Low Hill Road
    Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Great BritainBritish66789210001
    SMITH, Martin Christopher Geoffrey
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71281420001
    STUBBS, Robert John
    40 Tolmers Road
    Cuffley
    EN6 4JF Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    40 Tolmers Road
    Cuffley
    EN6 4JF Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40694340001
    TREE, David George
    East Wickham 59 College Lane
    Hurstpierpoint
    BN6 9AD Hassocks
    West Sussex
    Amministratore
    East Wickham 59 College Lane
    Hurstpierpoint
    BN6 9AD Hassocks
    West Sussex
    British64855130001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritish12317760001
    WHARTON, Robert Victor
    Seven Clare Drive
    Edgbaston
    B15 3LP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Seven Clare Drive
    Edgbaston
    B15 3LP Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish3640880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Kelvin William Thomas Hingley
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    06 apr 2016
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Nigel Stuart Bell
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    06 apr 2016
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    KELNIGAL GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 apr 2013
    Consegnato il 10 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Trade mark: hp-high point. Class: 16. registration number: 1074975. notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • 20-20 Trustees Limited
    • Bridge Trustees Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2010
    Consegnato il 04 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 lug 2005
    Consegnato il 27 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Arab National Bank
    Transazioni
    • 27 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high-point europe limited, vantagepoint management consultants (public sector) limited
    Creato il 04 lug 2001
    Consegnato il 24 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 feb 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Book debts and all the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 10 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the facility agreement being the master facilities agreement dated 9 june 1997 (as therein defined)
    Brevi particolari
    The agreement being the placing and offer agreement dated 10/6/97 relating to a placing and open offer of ordinary shares of 1P each in high-point PLC and the benefit of the same and assigns all right title and interest in and to all moneys owing under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 09 ott 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 1989
    Consegnato il 20 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1986
    Consegnato il 05 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    No 11 amen lodge ave. Maria lane l/b or the city of london t/no - lgl 427936.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1986
    Consegnato il 05 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The penthouse, amen lodge ave, maria lane l/borne city of london t/no-ngl 137194.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 1985
    Consegnato il 06 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situate and known as the penthouse amen lodge, warwick lane london EC4 title no ngl 137194 and flat 11 amen lodge warwick lane london EC4 title no ngl 427936 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • City Bank N.A.
    Transazioni
    • 06 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 lug 1982
    Consegnato il 15 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1980
    Consegnato il 06 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 6TH & part 7TH floor of king edward house, new st. Birmingham B2 4QW. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 ago 1980
    Consegnato il 21 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2A highfield road, dartford kent, title no k 464228. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0