KELNIGAL GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KELNIGAL GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00979170 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KELNIGAL GROUP LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 200 Great Dover Street SE1 4YB London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HIGH-POINT RENDEL GROUP LIMITED | 26 feb 2007 | 26 feb 2007 |
| HIGH-POINT RENDEL GROUP PLC | 14 gen 1998 | 14 gen 1998 |
| HIGH-POINT PLC | 06 ott 1988 | 06 ott 1988 |
| HIGH-POINT SERVICES GROUP PLC | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| HIGH-POINT CONTRACT SERVICES LIMITED | 08 mag 1970 | 08 mag 1970 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2016 al 30 set 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 61 Southwark Street London SE1 1SA a 200 Great Dover Street London SE1 4YB in data 06 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 12 gen 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed high-point rendel group LIMITED\certificate issued on 04/08/15 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 009791700014 in pieno | 6 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 19 apr 2014 al 31 mar 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 19 apr 2013 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2013 al 19 apr 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 009791700014 | 191 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSONS, Charlotte Louise | Segretario | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | Other | 135626530001 | ||||||
| BELL, Nigel Stuart | Amministratore | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | United Kingdom | British | 91913690001 | |||||
| HINGLEY, Kelvin William Thomas | Amministratore | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | United Kingdom | British | 50467220002 | |||||
| PARSONS, Charlotte Louise | Amministratore | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | United Kingdom | British | 140414820004 | |||||
| BEST, John David | Segretario | Milbanke 43 Lady Byron Lane Knowle B93 9AX Solihull West Midlands | British | 2810080001 | ||||||
| DAVISON, Suzanne | Segretario | 106a Coppermill Lane Walthamstow E17 7HE London | British | 80856470001 | ||||||
| DESMOND, Pat | Segretario | 7 Regents Drive BR2 6BU Keston Kent | British | 52839700001 | ||||||
| DIXON, Leslie Albert | Segretario | 167 St Bernards Road B92 7DH Solihull West Midlands | British | 3640870001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Segretario | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Segretario | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Segretario | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Segretario | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| TRENDELL, William Anthony | Segretario | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | British | 12317760001 | ||||||
| BENNETT, Melvin Eugene | Amministratore | 2016 Bulrush Lane Cardiff By The Sea FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa | American | 43502520002 | ||||||
| DESMOND, Pat | Amministratore | 7 Regents Drive BR2 6BU Keston Kent | British | 52839700001 | ||||||
| DIXON, Leslie Albert | Amministratore | 167 St Bernards Road B92 7DH Solihull West Midlands | British | 3640870001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Amministratore | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Amministratore | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| HOOKWAY, David Wilfred | Amministratore | 68 Hartley Old Road CR8 4HJ Purley Surrey | British | 374710001 | ||||||
| JOHNSON, Peter | Amministratore | 54 Mymms Drive Brookmans Park AL9 7AF Hatfield Hertfordshire | British | 11342310001 | ||||||
| PALMER, Horace Anthony | Amministratore | Fairfield London Road Sunninghill SL5 0PH Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 45646020002 | |||||
| PERREY, Derek Randall | Amministratore | Oaklands Rockbear Hill Marsh Green EX5 2EZ Exeter | British | 12614160001 | ||||||
| REEVES, Ian William | Amministratore | Hewletts Mill Galhampton BA22 7BG Yeovil Somerset | British | 71881990001 | ||||||
| REEVES, Ian William | Amministratore | Hewletts Mill Galhampton BA22 7BG Yeovil Somerset | British | 71881990001 | ||||||
| SHEPPARD, Allen John George, The Right Honourable Lord | Amministratore | Didgmere Hall Low Hill Road Roydon CM19 5JN Harlow Essex | Great Britain | British | 66789210001 | |||||
| SMITH, Martin Christopher Geoffrey | Amministratore | 9 Finlarigg Drive Edgbaston B15 3RH Birmingham West Midlands | England | British | 71281420001 | |||||
| STUBBS, Robert John | Amministratore | 40 Tolmers Road Cuffley EN6 4JF Potters Bar Hertfordshire | United Kingdom | British | 40694340001 | |||||
| TREE, David George | Amministratore | East Wickham 59 College Lane Hurstpierpoint BN6 9AD Hassocks West Sussex | British | 64855130001 | ||||||
| TRENDELL, William Anthony | Amministratore | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | England | British | 12317760001 | |||||
| WHARTON, Robert Victor | Amministratore | Seven Clare Drive Edgbaston B15 3LP Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 3640880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Kelvin William Thomas Hingley | 06 apr 2016 | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Nigel Stuart Bell | 06 apr 2016 | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
KELNIGAL GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 22 apr 2013 Consegnato il 10 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Trade mark: hp-high point. Class: 16. registration number: 1074975. notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 mag 2010 Consegnato il 04 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 lug 2005 Consegnato il 27 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high-point europe limited, vantagepoint management consultants (public sector) limited | Creato il 04 lug 2001 Consegnato il 24 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 16 feb 1999 Consegnato il 17 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Book debts and all the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment | Creato il 10 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the facility agreement being the master facilities agreement dated 9 june 1997 (as therein defined) | |
Brevi particolari The agreement being the placing and offer agreement dated 10/6/97 relating to a placing and open offer of ordinary shares of 1P each in high-point PLC and the benefit of the same and assigns all right title and interest in and to all moneys owing under the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 09 ott 1995 Consegnato il 12 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 giu 1989 Consegnato il 20 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 dic 1986 Consegnato il 05 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari No 11 amen lodge ave. Maria lane l/b or the city of london t/no - lgl 427936. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 dic 1986 Consegnato il 05 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The penthouse, amen lodge ave, maria lane l/borne city of london t/no-ngl 137194. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 gen 1985 Consegnato il 06 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property situate and known as the penthouse amen lodge, warwick lane london EC4 title no ngl 137194 and flat 11 amen lodge warwick lane london EC4 title no ngl 427936 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 lug 1982 Consegnato il 15 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 ott 1980 Consegnato il 06 ott 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold 6TH & part 7TH floor of king edward house, new st. Birmingham B2 4QW. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 11 ago 1980 Consegnato il 21 ago 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 2A highfield road, dartford kent, title no k 464228. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0