SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00980694 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NATWEST INVOICE FINANCE LIMITED | 03 gen 2006 | 03 gen 2006 |
| NATWEST COMMERCIAL SERVICES LIMITED | 11 ago 2003 | 11 ago 2003 |
| LOMBARD NATWEST COMMERCIAL SERVICES LIMITED | 30 set 1988 | 30 set 1988 |
| CREDIT FACTORING INTERNATIONAL LIMITED | 28 mag 1970 | 28 mag 1970 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Varie Document removal - | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 10 pagine | MA | ||||||||||
Varie Name correction from 'springwell street development (no.1) LIMITED' to 'springwell street developments (no.1) LIMITED' | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed natwest invoice finance LIMITED\certificate issued on 22/06/18 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Notifica di Rbs Invoice Finance Limited come persona con controllo significativo il 04 apr 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Notifica di Rbs Invoice Finance (Holdings) come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 4 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 23 nov 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 6 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Smith House Elmwood Avenue Feltham Middlesex TW13 7QD a 250 Bishopsgate London EC2M 4AA in data 22 set 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di John-Paul Thwaite come amministratore in data 31 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Duncan Cowie come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Edmund Lord come amministratore in data 01 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adam Holden come amministratore in data 01 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| LORD, Peter Edmund | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | 195549570001 | |||||||||
| THWAITE, John Paul | Amministratore | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 207973420001 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Segretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Segretario | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
| LEA, John Albert | Segretario | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | 1369400003 | ||||||||||
| LEWIS, Derek John | Segretario | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | 34423910002 | ||||||||||
| STRANAGHAN, Patricia Ann | Segretario | Flat 1 25 Somers Road RH2 9DY Reigate Surrey | British | 39114460001 | ||||||||||
| BARDRICK, Michael Jeffrey | Amministratore | Smith House Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Rbs Invoice Finance | England | British | 97155410002 | |||||||||
| BARNARD, Andrew David | Amministratore | Bell Road RH12 3QL Warnham Bell Cottage West Sussex | England | British | 137736080001 | |||||||||
| BEESTON, Alistair John | Amministratore | Three Oaks Vauxhall Lane Southborough TN4 0XD Tunbridge Wells Kent | British | 10670790001 | ||||||||||
| BLESSLEY, Andrew | Amministratore | 26 Rothesay Avenue TW10 5EA Richmond Surrey | British | 47642420001 | ||||||||||
| BRADLEY, Neil Joseph | Amministratore | Neidpath Shootersway Lane HP4 3NP Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 85614780002 | |||||||||
| BRIAN, Michael | Amministratore | 30 Highlands Road KT22 8NJ Leatherhead Surrey | British | 24633390001 | ||||||||||
| CARTE, Brian Addison | Amministratore | Fairfield Lodge Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 145559220001 | |||||||||
| COWIE, Ian Duncan | Amministratore | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 195617950001 | |||||||||
| GEE, Paul Robert | Amministratore | Rustlings Crossways Park RH20 2QZ West Chiltington West Sussex | British | 97455790001 | ||||||||||
| GREEP, William Henry | Amministratore | 3 Highlands Road GU9 0LX Farnham Surrey | British | 61454630001 | ||||||||||
| HANNAY, Melanie Jane | Amministratore | 35 Belgrave Road BN25 2EN Seaford East Sussex | England | British | 120022180001 | |||||||||
| HAYDEN, Peter David | Amministratore | 93 Little Green Lane KT16 9PS Chertsey Surrey | British | 51437390001 | ||||||||||
| HOLDEN, Adam | Amministratore | Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Smith House Middlesex | England | British | 185018800001 | |||||||||
| HOLLOWAY, Stuart Antony | Amministratore | 1 Potters Close TN25 4PX Ashford Kent | England | British | 68311830002 | |||||||||
| IBBETSON, Peter Richard | Amministratore | Ashpoles 91 High Street MK44 1PE Sharnbrook Bedfordshire | British | 51496680001 | ||||||||||
| JOHNSON, Jeffrey | Amministratore | Hill House 28 Maldon Road Danbury CM3 4QH Chelmsford Essex | British | 103077710001 | ||||||||||
| JONES, Kevan Alan | Amministratore | 34 Garrick Close KT12 5PA Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | 55489310001 | |||||||||
| JONES, Susan Myra | Amministratore | The Croft 23 Tylers Hill Road HP5 1XH Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 122741480001 | |||||||||
| LEA, John Albert | Amministratore | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | 1369400003 | ||||||||||
| LEGG, Robin Stewart | Amministratore | Winton Birch Close RH17 7ST Haywards Heath West Sussex | British | 144484210001 | ||||||||||
| MABERLY, Michael Alan | Amministratore | Endellion Money Row Green Holyport SL6 2NA Maidenhead Berkshire | British | 1288990001 | ||||||||||
| MCFARLANE, Ross William | Amministratore | Badgers Wood Beacon Road Ringshall HP4 1NE Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 54399140004 | |||||||||
| MEAD, Paul Richard | Amministratore | 28 Maple Court The Gables, Oxshott KT22 0SD Leatherhead Surrey | British | 64439800001 | ||||||||||
| MORIARTY, Antoinette Una | Amministratore | 555 Rayners Lane HA5 5HP Pinner Middlesex | British | 54206370002 | ||||||||||
| MORRIN, Martin John | Amministratore | Chaseley Drive CR2 0DN Sanderstead 1 Surrey England | England | Irish | 124121400001 | |||||||||
| NICHOLS, Lawrence Edward De Lisle | Amministratore | 143 French Street TW16 5JY Sunbury On Thames Middlesex | England | British | 310704240001 | |||||||||
| NICHOLS, Lawrence Edward De Lisle | Amministratore | 143 French Street TW16 5JY Sunbury On Thames Middlesex | England | British | 310704240001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPRINGWELL STREET DEVELOPMENTS (NO.1) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rbs Invoice Finance Limited | 04 apr 2018 | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Rbs Invoice Finance (Holdings) | 06 apr 2016 | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Rbs Invoice Finance (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Smith House Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0