NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED

NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00980864
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Windsor House
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Shropshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma24 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Soddisfazione dell'onere 1400 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 663 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 45 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 517 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 41 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2023

    20 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Reassure Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon James Thomlinson il 01 lug 2023

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Simon James Thomlinson come amministratore in data 01 lug 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Hilmar Cuhls come amministratore in data 30 giu 2023

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022

    20 pagineAA

    Nomina di Mr Craig Douglas Hamilton come amministratore in data 01 mag 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Rebecca Wainwright come amministratore in data 01 mag 2023

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 009808641468, creata il 17 apr 2023

    18 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 842 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1262 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 941 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mrs Rebecca Wainwright come amministratore in data 16 mar 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Charles Woodcock come amministratore in data 16 mar 2022

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 1129 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1029 in pieno

    2 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LTD
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Segretario
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03588041
    272294060001
    HAMILTON, Craig Douglas
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Windsor House
    United Kingdom
    Amministratore
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford Shropshire
    Windsor House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Conduct And Compliance Director266628230001
    THOMLINSON, Simon James
    Telford Town Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Telford Town Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    England
    United KingdomBritishActuary197266520002
    CHAMBERS, Mark Richard
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    Segretario
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    BritishSolicitor69321020002
    ENGLEDOW, Roger Charles
    13 Old Leicester Road
    Wansford
    PE8 6JR Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    13 Old Leicester Road
    Wansford
    PE8 6JR Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishFinance Manager10329830001
    MILLER, Edmund John Stephen
    Edenwood
    1a Brokes Road
    RH2 9LP Reigate
    Surrey
    Segretario
    Edenwood
    1a Brokes Road
    RH2 9LP Reigate
    Surrey
    British19991650001
    OPPAL, Abdul Munem
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    British116338770001
    SHAKESPEARE, Paul
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Segretario
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    BritishCompany Secretary135096740002
    THOMAS, Derek John
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Segretario
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British2297010001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritishCompany Director106900580001
    BRANCH, Peter Robert
    22 Pasture Road
    SG6 3LP Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Pasture Road
    SG6 3LP Letchworth
    Hertfordshire
    BritishAssistant General Manager (Administration)10178410002
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrishDirector63716360005
    COOKE, Alison Joan
    163 High Avenue
    Fearnhill Park
    SG6 3RR Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    163 High Avenue
    Fearnhill Park
    SG6 3RR Letchworth
    Hertfordshire
    BritishClaims Manager47934980001
    COWDERY, Clive Adam
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Amministratore
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    BritishNone88183990001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Amministratore
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritishAccountant89585440001
    CUHLS, Matthew Hilmar
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Amministratore
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    EnglandBritishChief Executive36427940004
    DAVIES, Roger William
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    BritishActuary21933520001
    DOLFI, Douglas Scott
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    Amministratore
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    AmericanDirector78292660001
    HASLAM, Alan Robert
    72 Icknield Close
    Ickleford
    SG5 3TE Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    72 Icknield Close
    Ickleford
    SG5 3TE Hitchin
    Hertfordshire
    BritishManager - Small Self Administered Schemes10159560001
    HASTINGS, David James
    48 Redhoods Way East
    SG6 4DF Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    48 Redhoods Way East
    SG6 4DF Letchworth
    Hertfordshire
    BritishAssistant Manager - Small Self61663140002
    HAYNES, Stephen Robert
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishDirector79961770002
    HILL, Gavin Henry Ellis
    26a High Street
    Pirton
    SG5 3PT Hitchin
    Wilbury
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    26a High Street
    Pirton
    SG5 3PT Hitchin
    Wilbury
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGeneral Manager9918480002
    HOWE, Robert William Albert
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkBritishGroup Chief Actuary13105310003
    KNIGHT, Stephen Paul Andrew
    2 Garland Court
    Crownhill
    MK8 0LE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Garland Court
    Crownhill
    MK8 0LE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector97413050001
    LOWE, David Andrew
    63 Hampden Road
    SG4 0LB Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    63 Hampden Road
    SG4 0LB Hitchin
    Hertfordshire
    BritishMarketing Manager90885650001
    LOWE, David Andrew
    1 Montgomery Avenue
    SG17 5UA Shefford
    Bedfordshire
    Amministratore
    1 Montgomery Avenue
    SG17 5UA Shefford
    Bedfordshire
    BritishManager56808000002
    MEAD, Michael William
    9 Tulip Close
    SG18 8TR Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    9 Tulip Close
    SG18 8TR Biggleswade
    Bedfordshire
    BritishCorporate Pensions Manager65557660001
    MILLER, Edmund John Stephen
    Edenwood
    1a Brokes Road
    RH2 9LP Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Edenwood
    1a Brokes Road
    RH2 9LP Reigate
    Surrey
    BritishCompany Secretary19991650001
    PEARCE, Gareth David
    5 St Simons Avenue
    SW15 6DU London
    Amministratore
    5 St Simons Avenue
    SW15 6DU London
    United KingdomBritishChartered Accountant35531810001
    READING, Christopher
    12 Highfield
    SG6 3QD Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Highfield
    SG6 3QD Letchworth
    Hertfordshire
    BritishPensions Operations Manager10159580001
    SINGLETON, Graham Lloyd
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Amministratore
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritishCeo146222860002
    SWALLOW, Mark Francis
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    EnglandBritishDirector123455540001
    TAYLOR, Richard Stuart
    11 Doncaster Close
    SG1 5RY Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Doncaster Close
    SG1 5RY Stevenage
    Hertfordshire
    BritishCompliance Officer Pensions Technical Support Mana10159590002
    WAINWRIGHT, Rebecca
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    United KingdomBritishStrategy And Planning Director293978430001
    WILSON, Wilson Weldon
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    AmericanCompany Director111949890001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ironmasters Way
    Town Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    England
    06 apr 2016
    Ironmasters Way
    Town Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione754167
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 apr 2023
    Consegnato il 19 apr 2023
    In corso
    Breve descrizione
    Freehold property known as 70 acres of land at sessay.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 giu 2021
    Consegnato il 08 giu 2021
    In corso
    Breve descrizione
    The old salvation army hall 9 bull close norwich t/no NK251987.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 21 ago 2019
    Consegnato il 05 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    5A and 5B royal oak place matlock street bakewell.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Security Trustee Limited
    Transazioni
    • 05 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 21 ago 2019
    Consegnato il 05 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    145 church street whitby north yorkshire.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Security Trustees Limited
    Transazioni
    • 05 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 mag 2018
    Consegnato il 04 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The old court house. Church road. East harling. Norfolk. NR16 2NB.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 set 2016
    Consegnato il 05 ott 2016
    In corso
    Breve descrizione
    212-216 linthorpe road, middlesbrough, TS1 3QW.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 ott 2016Dichiarazione della società che agisce come trustee su un'ipoteca (MR06)
    A registered charge
    Creato il 12 mag 2016
    Consegnato il 17 mag 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Basement, ground and first floor premises at 7 high street, tenby, pembrokershire SA70 7EU as registered at the land registry with title number CYM274996.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 17 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 ott 2015
    Consegnato il 04 nov 2015
    In corso
    Breve descrizione
    All that freehold property known as 91 high street, rayleigh, essex, SS6 7EJ as the same is registered at hm land registry under title number: EX206940.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transazioni
    • 04 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 set 2015
    Consegnato il 17 set 2015
    In corso
    Breve descrizione
    50 market street, falmouth, TR11 3AB.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 apr 2015
    Consegnato il 10 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    A legal mortgage over the freehold property known as woodlands nursery school 1 - 3 orchard road barnet hertfordshire. Hm land registry title number(s) NGL233117: NGL115358.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 apr 2015
    Consegnato il 10 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    A legal mortgage over the freehold property known as miles house dunsford place bath. Hm land registry title number(s) AV219151.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2014
    Consegnato il 15 nov 2014
    In corso
    Breve descrizione
    F/H property k/a 38 winsor road & 33/34 hickman road penarth cardiff t/no. WA855120.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 15 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 lug 2014
    Consegnato il 01 ago 2014
    In corso
    Breve descrizione
    145 church street, whitby, north yorkshire t/no:NYK249878.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 01 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 ott 2019Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Charge
    Creato il 31 gen 2012
    Consegnato il 08 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33 belmore street enniskillen, folio FE84725 county fermanagh; together with all machinery, utensils, chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal mortgage
    Creato il 14 dic 2011
    Consegnato il 15 dic 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company being the trustees for the time being of the national mutual personal pension scheme to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 14 montpellier walk, cheltenham t/no GR191016; with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 20 ott 2011
    Consegnato il 21 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H colburn house querns road cirencester t/no GR150952 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 20 ott 2011
    Consegnato il 21 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 4 5A and 5 the old george fountain street nailsworth gloucestershire t/no GR242647 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 24 giu 2011
    Consegnato il 28 giu 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H binnings house 4-6 high street eastleigh hampshire t/no HP439014; together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 2010
    Consegnato il 14 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H 31-33 branch road batley with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage and charge
    Creato il 15 ott 2010
    Consegnato il 25 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 7 ravenhill business park ravenhill road belfast folios DN156148L county down and AN25792L county antrim.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Third party legal charge
    Creato il 07 set 2010
    Consegnato il 22 set 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company as the trustees from time to time of the national mutual personal pension scheme relating to arrangement number 004507AWIL to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 1 and 2 pendle mill mill lane gisburn lancashire t/no LA841591; by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal mortgage
    Creato il 13 ago 2010
    Consegnato il 17 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 37-39 and 45 market street bridgend mid glamorgan t/nos WA797583 and WA267924 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 05 feb 2010
    Consegnato il 13 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H ground floor and basement 16 butter market ipswich together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 02 feb 2010
    Consegnato il 13 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H byre court sandys road malvern worcestershire t/n HW182919 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 05 giu 2009
    Consegnato il 06 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H miles house dunsford place bathwick hill bath t/n AV219151 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)

    NAMULAS PENSION TRUSTEES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 giu 1990Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Stupples
    King Sturge Llp
    40 Berkeley Square
    BS8 1HU Bristol
    Praticante
    King Sturge Llp
    40 Berkeley Square
    BS8 1HU Bristol
    Richard Charles Batten
    40 Berkeley Square
    Bristol
    BS8 1HU
    Praticante
    40 Berkeley Square
    Bristol
    BS8 1HU
    2
    DataTipo
    02 lug 1990Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Edward Cookson
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    Praticante
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    Peter Alexander Bache
    45 Church Stree
    Birmingham
    3
    Praticante
    45 Church Stree
    Birmingham
    3
    3
    DataTipo
    28 mar 2001Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Richard Jennings
    Edward Symmons Llp
    Cloister House
    M3 5AG Riverside
    New Bailey Street Manchester
    Praticante
    Edward Symmons Llp
    Cloister House
    M3 5AG Riverside
    New Bailey Street Manchester
    Christopher Price
    Cloister House
    Riverside
    M3 5AG New Bailey Street
    Manchester
    Praticante
    Cloister House
    Riverside
    M3 5AG New Bailey Street
    Manchester
    4
    DataTipo
    22 nov 1996Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Elijah Thomas Bowen
    Pricewaterhousecoopers
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    David James Waterhouse
    Pricewaterhousecoopers
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0