JACKSON LLOYD LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JACKSON LLOYD LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00981979 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JACKSON LLOYD LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova JACKSON LLOYD LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 1390 Montpellier Court Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester Gloucestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JACKSON LLOYD LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JACKSON LLOYD (D.B.M.) LIMITED | 30 mar 1989 | 30 mar 1989 |
| W.V. JACKSON LIMITED | 12 giu 1970 | 12 giu 1970 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JACKSON LLOYD LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per JACKSON LLOYD LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 163 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 24 mag 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ben Robert Westran il 17 feb 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ben Robert Westran il 17 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di JACKSON LLOYD LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTRAN, Ben Robert | Segretario | Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester Unit 1390 Montpellier Court Gloucestershire | British | 155011160001 | ||||||||||
| WESTRAN, Ben Robert | Amministratore | Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester Unit 1390 Montpellier Court Gloucestershire | United Kingdom | British | 127102240004 | |||||||||
| MEARS GROUP PLC | Amministratore | Montpellier Court Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Gloucester |
| 149799340001 | ||||||||||
| LLOYD, William Anthony | Segretario | The Coach House Miry Lane WN8 7TA Parbold Lancashire | British | 29346370002 | ||||||||||
| LLOYD, William Anthony | Segretario | The Coach House Miry Lane WN8 7TA Parbold Lancashire | British | 29346370002 | ||||||||||
| NIELD, Philip Roy | Segretario | 2 Paddock Road WN8 9PL Skelmersdale Lancashire | British | 127349170001 | ||||||||||
| YARWOOD, Steve | Segretario | Brock House Brock Road PR3 0XD Great Eccleston Lancashire | British | 108341250001 | ||||||||||
| YATES, Stuart William | Segretario | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | British | 108370390001 | ||||||||||
| BAINBRIDGE, Laurence George | Amministratore | 7 Brooklet Close OL4 5UB Springhead Saddleworth | British | 99170990001 | ||||||||||
| BATTERTON, David | Amministratore | 1 Hazlewood Close WA8 8GF Widnes Cheshire | England | British | 108341180001 | |||||||||
| CHISNALL, Gary John | Amministratore | No 1 Wilsham Road Orrell WN5 8SF Wigan | England | British | 108456000003 | |||||||||
| CLEARY, David John | Amministratore | No 4 Smethurst Hall Park Billinge WN5 7DR Wigan Lancashire | British | 29346390002 | ||||||||||
| CLEARY, Michael Dennis | Amministratore | 58a Bank Top Roby Mill WN8 0QH Skelmersdale Lancashire | England | British | 65107610001 | |||||||||
| COE, Stephen | Amministratore | North Croft M46 0SW Atherton 7 Greater Manchester | England | British | 128014030001 | |||||||||
| HINSHELWOOD, Wallace Simon Duthie | Amministratore | 11 Wheelwrights Close CM23 4GH Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 91642420002 | |||||||||
| LLOYD, William Anthony | Amministratore | The Coach House Miry Lane WN8 7TA Parbold Lancashire | United Kingdom | British | 29346370002 | |||||||||
| LLOYD, William Gerard | Amministratore | 9 Grove Road Upholland WN8 0LH Skelmersdale Lancashire | British | 29346400001 | ||||||||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Amministratore | Murrayfield 13 Windsor Road SL9 7NB Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||||||
| SPELLACY, Jane Ann | Amministratore | Lindsay Cottage Crawford Road Crawford Village WN8 9QP Upholland West Lancashire | England | British | 156913190001 | |||||||||
| WILLIAMS, Duncan | Amministratore | 10 Torrin Drive SY3 6AW Shrewsbury Salop | United Kingdom | British | 127844370001 | |||||||||
| YARWOOD, Steve | Amministratore | Brock House Brock Road PR3 0XD Great Eccleston Lancashire | United Kingdom | British | 108341250001 | |||||||||
| YATES, Stuart William | Amministratore | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | 108370390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di JACKSON LLOYD LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mears Limited | 06 apr 2016 | Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Montepellier Court Gloucester United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
JACKSON LLOYD LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession to a debenture dated 21 april 2008 and | Creato il 22 dic 2010 Consegnato il 08 gen 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from a chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 22 nov 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become from any of the companies to the junior lenders and the senior lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 15 set 2005 Consegnato il 20 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 set 2005 Consegnato il 20 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 13 lug 1992 Consegnato il 21 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 2 kilshaw street wigan greater manchester title no GM460335 floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 16 dic 1988 Consegnato il 21 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 24 nov 1986 Consegnato il 27 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the westerly side of glebe end street wigan greater manchester t no:- gm 366080 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 21 mar 1986 Consegnato il 02 apr 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H. property known as 15/17 sandbrook road up holland near wigan and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0