G & A E SLINGSBY LIMITED

G & A E SLINGSBY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG & A E SLINGSBY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00982921
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G & A E SLINGSBY LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEOLITH LIMITED01 dic 198901 dic 1989
    NEOLITH CHEMICALS LIMITED24 giu 197024 giu 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 08 set 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium & undistributable reserves cancelled 31/08/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert Andrew Ross Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Webster il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Alison Drew il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 lug 2009

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2007

    5 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 lug 2006

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2005

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Segretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Amministratore
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150753930001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Amministratore
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritishCompany Director40201730005
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Amministratore
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    MORRIS, Anthony Charles
    42 Walnut Way
    Hyde Heath
    HP6 5SD Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    42 Walnut Way
    Hyde Heath
    HP6 5SD Amersham
    Buckinghamshire
    British28467660001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Segretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    SMITH, Brian Frederick
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    Segretario
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    British6030670001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    British11797040001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director/Secretary272310001
    BUCKETT, Cecil John
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director690420001
    EARNSHAW, Allan
    Sandy Field 566 Newchurch Road
    Rawtenstall
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    Sandy Field 566 Newchurch Road
    Rawtenstall
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director10010090001
    HAYHURST, Kevin
    7 Heath Hill Drive
    Stacksteads
    OL13 0SG Bacup
    Lancashire
    Amministratore
    7 Heath Hill Drive
    Stacksteads
    OL13 0SG Bacup
    Lancashire
    BritishCompany Director21410340001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Amministratore
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    POOLE, Kenneth Eccles
    15 Waingap Rise
    Syke
    OL12 9TZ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    15 Waingap Rise
    Syke
    OL12 9TZ Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Director6505570001
    SMITH, Brian Frederick
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    Amministratore
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishDirector6030670001
    STANTON, Brian William
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    Amministratore
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    BritishDirector14648180001
    WADSWORTH, Christopher Robert
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    BritishCompany Director27227340001
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Amministratore
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishSolicitor82978250002
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Secretary11797040001

    G & A E SLINGSBY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 apr 1992
    Consegnato il 06 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the goodwill,book debts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 22 ago 1988
    Consegnato il 25 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1988Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1985
    Consegnato il 10 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hydraulic equipment as listed on schedule to doc M18.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Credit Services Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1985Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1983
    Consegnato il 29 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and bldgs to the nw of the green, houghton le spring, sunderland. Title no ty 56641 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1983
    Consegnato il 29 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot of land & bldgs erected thereon k/a unit 15 glebe farm road, rugby warwickshire title no wk 249722 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental debenture
    Creato il 26 mar 1981
    Consegnato il 03 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge on all book debts & other debts both present & future.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank
    Transazioni
    • 03 apr 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0