FIRST OIL SNS LIMITED

FIRST OIL SNS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIRST OIL SNS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00986309
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIRST OIL SNS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FIRST OIL SNS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FIRST OIL SNS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CALEDONIA SNS LIMITED07 nov 200307 nov 2003
    CONSORT NORTH SEA LIMITED06 feb 200206 feb 2002
    ENTERPRISE OIL NORTH SEA LIMITED10 set 200110 set 2001
    PETROBRAS NORTH SEA LIMITED30 giu 199830 giu 1998
    SANTOS EUROPE LIMITED16 apr 199216 apr 1992
    PEKO EXPLORATION (UK) LIMITED17 lug 199017 lug 1990
    IU OIL & GAS LIMITED06 ago 197006 ago 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIRST OIL SNS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FIRST OIL SNS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FIRST OIL SNS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2015

    Stato del capitale al 03 lug 2015

    • Capitale: GBP 41,599,622
    SH01

    Cessazione della carica di Steven Richard George come amministratore in data 05 giu 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    PARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 lug 2014

    Stato del capitale al 04 lug 2014

    • Capitale: GBP 41,599,622
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Steven Richard George come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    3 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 30 apr 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Stephen Grant come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Graham Forbes come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Alexander Suttie il 19 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Graham Andrew Forbes il 19 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Stephen Grant il 19 ott 2009

    1 pagineCH03

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Authorised to enter into a second amendment and restatement agreement, a subordination deed and a guarantee and debenture 30/07/2009
    RES13

    Chi sono gli amministratori di FIRST OIL SNS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SUTTIE, Ian Alexander, Mr.
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishDirector52794240001
    BATE, Christopher Malcolm
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    Segretario
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    British77942170001
    GEORGE, Steven Richard
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    Segretario
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    OtherChartered Accountant126930530001
    GRANT, Stephen
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Segretario
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant139292040001
    LONGMAN, Christopher David, Dr
    Staplow House
    Staplow
    HR8 1NP Ledbury
    Herefordshire
    Segretario
    Staplow House
    Staplow
    HR8 1NP Ledbury
    Herefordshire
    British58438680001
    MCKENZIE, William Ernest
    8 Harbury Dell
    LU3 3XH Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    8 Harbury Dell
    LU3 3XH Luton
    Bedfordshire
    British60573240002
    MEARNS, Steven Macdonald
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115242820001
    PENNEY, Nigel Francis
    13 Downs Court
    Commonside Close
    SM2 5SX Sutton
    Surrey
    Segretario
    13 Downs Court
    Commonside Close
    SM2 5SX Sutton
    Surrey
    British97198480001
    SMITH, Vernon Victor
    Long Acre Paice Lane
    Medstead
    GU34 5PT Alton
    Hampshire
    Segretario
    Long Acre Paice Lane
    Medstead
    GU34 5PT Alton
    Hampshire
    British10991580001
    STOUGH, Kenneth Fred
    Rossend Guildown Road
    GU2 5ET Guildford
    Surrey
    Segretario
    Rossend Guildown Road
    GU2 5ET Guildford
    Surrey
    British39588630001
    TEMPLETON, Michael Charles
    Lothorien Barley Mow Hill
    Headley Down
    GU35 8AB Bordon
    Hampshire
    Segretario
    Lothorien Barley Mow Hill
    Headley Down
    GU35 8AB Bordon
    Hampshire
    British63244900001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    BritishSolicitor82978250001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Segretario
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Segretario
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    ADLER, Norman Ross
    11 The Avenue
    Medindie
    South Australia
    5081
    Australia
    Amministratore
    11 The Avenue
    Medindie
    South Australia
    5081
    Australia
    AustralianManaging Director11260180001
    ARMOUR, Andrew Richard, Doctor
    Little Triton
    London Road
    OX11 9PD Blewbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Little Triton
    London Road
    OX11 9PD Blewbury
    Oxfordshire
    BritishGeophysicist81558280001
    ARMSTRONG, John Dennis, Doctor
    127 Hickory Ridge
    Houston
    77024
    Usa
    Amministratore
    127 Hickory Ridge
    Houston
    77024
    Usa
    AustralianExecutive General Manager30215120002
    BARBOSA, Gustavo Tardin
    30a Hornton Street
    W8 4NR London
    Amministratore
    30a Hornton Street
    W8 4NR London
    BrazilianEngineer55726770001
    BARBOSA, Jose Coutinho
    Arto 102 Lazza
    Av Linea De Paula Machado 896
    FOREIGN Rio De Janeriro Rj Brazil
    Amministratore
    Arto 102 Lazza
    Av Linea De Paula Machado 896
    FOREIGN Rio De Janeriro Rj Brazil
    BrazilianChairman59424820002
    BASTOS, Bravlio Luis Cortes Xavier
    Flat 2 41 Emperors Gate
    SW7 4HJ London
    Amministratore
    Flat 2 41 Emperors Gate
    SW7 4HJ London
    BrazilianCompany Director56186420001
    BELL, Andrew Stewart
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    Amministratore
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    United KingdomBritishAccountant95066820001
    BERTANI, Renato Tadeu
    Flat 14 Stanford Court
    Cornwall Gardens
    SW7 4AB London
    Amministratore
    Flat 14 Stanford Court
    Cornwall Gardens
    SW7 4AB London
    BrazilianOil Company Executive59369040001
    BOWEN, John Myles, Dr
    Rudge Farm
    Lustleigh
    TQ13 9SL Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Rudge Farm
    Lustleigh
    TQ13 9SL Newton Abbot
    Devon
    BritishPetroleum Consultant34840710002
    CAMARGO, Jorge Margues De Toledo
    Rua Almirante Sadock De Sa
    370/101 Ipanema
    FOREIGN Rio De Janeiro
    22 471 030
    Brazil
    Amministratore
    Rua Almirante Sadock De Sa
    370/101 Ipanema
    FOREIGN Rio De Janeiro
    22 471 030
    Brazil
    BrazilianOil Company Executive65772390001
    CRAIG, Ian
    The Georgian House
    4 Farmleigh Grove Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Georgian House
    4 Farmleigh Grove Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    BritishTechnical Director78821300001
    DA SILVA, Marcello Castilho
    Flat 8 10 Hornton Street
    W8 4NW London
    Amministratore
    Flat 8 10 Hornton Street
    W8 4NW London
    BrazilianDirector76080340001
    DOWN, Kenneth John, Mr.
    246 Dewar Terrace
    Corinda
    Brisane
    4075
    Australia
    Amministratore
    246 Dewar Terrace
    Corinda
    Brisane
    4075
    Australia
    AustraliaAustralianEconomist217984760001
    EDGLEY, Steven Neville
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director85718530001
    FERGUSON, Donald
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    Amministratore
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    BritishDirector88767730001
    FITZGERALD, John Bryan
    146 Strangways Terrace
    FOREIGN North Adelaide
    S A 5006
    Australia
    Amministratore
    146 Strangways Terrace
    FOREIGN North Adelaide
    S A 5006
    Australia
    AustralianCompany Director26970340001
    FORBES, Graham Andrew
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishChartered Accountant83876980001
    GEORGE, Steven Richard
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    Amministratore
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant161491510001
    HAWKINS, Warren
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    Amministratore
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    AmericanSenior Vice President94520330001
    HICKAM, Edward Eugene
    6230 Coral Ridge
    Houston
    Texas
    Usa
    Amministratore
    6230 Coral Ridge
    Houston
    Texas
    Usa
    AmericanCompany Director43831180001

    FIRST OIL SNS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 ott 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee Foritself and for and on Behalf of the Finance Parties)
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as consort north sea limited to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of an equitable mortgage all shares in any member of the group, by way of a floating charge its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities owned by it or held by any nominee on its behalf.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Trustee Fore Itself and the Secured Creditors
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 17 feb 2003
    Consegnato il 20 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the "facility agent") as facility agent and trustee for the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the assigned assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1998
    Consegnato il 12 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and petrobras U.K. limited to any finance party under each financing document (both as defined) and under this debenture
    Brevi particolari
    All property and rights,title and interest whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Security Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 12 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0