REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED

REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00986376
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gotham Road
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WIRELINE INVESTMENTS LIMITED01 apr 199401 apr 1994
    BPB INSTRUMENTS INTERNATIONAL LIMITED24 mar 198624 mar 1986
    ISLE OF ELY PAPER SACKS LIMITED07 ago 197007 ago 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di Mr Neil Alexander Macleod come amministratore in data 28 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Jones come amministratore in data 28 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 lug 2014

    Stato del capitale al 10 lug 2014

    • Capitale: GBP 10,007,490
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Nomina di Ms Julie Mary Thomson come amministratore in data 27 ago 2013

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Gemma Rose-Garvie come segretario in data 27 ago 2013

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Brian Moncur come segretario in data 27 ago 2013

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Brian Moncur come amministratore in data 05 ago 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Euan Robertson Prentice come amministratore in data 04 set 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Gray Fulton come amministratore in data 04 set 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Jones il 22 giu 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Gray Fulton il 22 giu 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Brian Moncur il 22 giu 2011

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da Gotham Road East Leake Loughborough Leicestershire LE12 6JX in data 16 mag 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROSE-GARVIE, Gemma
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    180875850001
    MACLEOD, Neil Alexander
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    Amministratore
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    ScotlandBritish177581770001
    PRENTICE, Euan Robertson
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Amministratore
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    ScotlandBritish168927430001
    THOMSON, Julie Mary
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    ScotlandBritish171856740001
    ATKIN, James Reginald
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    British55311660001
    ATKIN, James Reginald
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Laurel Cottage Tithby Road
    Cropwell Butler
    NG12 3AA Nottingham
    Nottinghamshire
    British55311660001
    FULTON, William Gray
    2
    Lawson Drive Dyce
    AB21 0DR Aberdeen
    Weatherford House
    United Kingdom
    Segretario
    2
    Lawson Drive Dyce
    AB21 0DR Aberdeen
    Weatherford House
    United Kingdom
    British138793410001
    HYDE, Robin Anthony
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    Segretario
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    British14363830002
    MONCUR, Brian
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    146420320001
    WROOT, Richard Wilson
    25 Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    Segretario
    25 Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    British73604700002
    BECKETT, Michael Ernest
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    Amministratore
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    British118661100001
    BOYES, John Stewart
    Cosford Hall Farm
    Cosford
    CV21 1HT Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cosford Hall Farm
    Cosford
    CV21 1HT Rugby
    Warwickshire
    UkBritish10479120001
    FULTON, William Gray
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139048390001
    HYDE, Robin Anthony
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    56 Belper Road
    DE1 3EN Derby
    Derbyshire
    British14363830002
    JONES, Ian
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    East Leake
    LE12 6JX Loughborough
    Gotham Road
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish57632040002
    MARTIN, Burt Michael
    4817 Welford
    77401 Bellaire
    Texas
    Amministratore
    4817 Welford
    77401 Bellaire
    Texas
    United States74615750001
    MCNULTY, Michael Joseph
    1121 Wentworth View S.W.
    Calgary
    Alberta
    T3h 5k3
    Canada
    Amministratore
    1121 Wentworth View S.W.
    Calgary
    Alberta
    T3h 5k3
    Canada
    Canadian100108550001
    MONCUR, Brian
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish118915490001
    REEVES, Donald Richard
    Lindum House Grantham Road
    Whatton
    NG13 9EU Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Lindum House Grantham Road
    Whatton
    NG13 9EU Nottingham
    Nottinghamshire
    British14037750001
    SPENCER, Michael Charles
    Cleeve House
    Melton Road Hickling Pastures
    LE14 3QG Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Cleeve House
    Melton Road Hickling Pastures
    LE14 3QG Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish14363850002
    SYDNEY-SMITH, Peter Edward
    Laundry House Laundry Lane
    Heckfield
    RG27 0LF Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Laundry House Laundry Lane
    Heckfield
    RG27 0LF Basingstoke
    Hampshire
    British13962530002
    WHATMOUGH, Michael John
    41 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    41 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    British13032520001

    REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 11 lug 1995
    Consegnato il 28 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including (without limitation) pursuant to the facilities agreement
    Brevi particolari
    The company as security for the obligations assigns mortgages charges hypoothecates and pladges to the bank the shares. The charge provides that the pledged shares shall include any substitution therefor, additions thereto or proceeds thereof, arising out of any consolidation, subdivision, reclassification, stock dividend or similar increase or decrease in or alteration of the capital of the issuer of thepledged shares (the "issuer") or any other event.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez
    Transazioni
    • 28 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 lug 1995
    Consegnato il 21 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever including but not limited to under the facilities agreement dated 11TH july 1995
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez
    Transazioni
    • 21 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 set 2014Inizio della liquidazione
    13 apr 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ewen R. Alexander
    Bishops Court 29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Praticante
    Bishops Court 29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Aberdeenshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0