MATLODGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMATLODGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00986450
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MATLODGE LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova MATLODGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Jubilee Place
    London
    SW3 3TQ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MATLODGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MATLODGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Edward Glover come amministratore

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2011

    Stato del capitale al 21 gen 2011

    • Capitale: GBP 1.01
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Karen Lyon il 02 nov 2010

    2 pagineCH03

    Stato del capitale al 04 nov 2010

    • Capitale: GBP 1.01
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew David John Moffat il 04 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Arunkumar Bhilalbhai Desai il 09 feb 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del direttore cambiati per Edward Douglas Glover il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Karen Lyon il 28 set 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MATLODGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LYON, Karen
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Other140536930001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Amministratore
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishGroup Accoutant84225840001
    MOFFAT, Andrew David John
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Amministratore
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    EnglandBritishMerchant Banker34399870003
    BANDEL, Martin Howard
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    British37249220002
    COLE, Jennifer
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    Segretario
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    British74489480002
    FORSTER, Helen
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    Segretario
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    British106129360001
    MILLER, Philip
    Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    87
    Segretario
    Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    87
    Other128209650001
    POOLE, Rebecca Louise
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    Segretario
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    British92013940001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Segretario
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    British5463920001
    WILBY, Hannah Louise
    Flat 2
    61 Ferndale Road, Clapham
    SW4 7RL London
    Segretario
    Flat 2
    61 Ferndale Road, Clapham
    SW4 7RL London
    British114836060001
    PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    Segretario
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    76827740001
    ALLPORT, Howard Coplestone
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    Amministratore
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    BritishCompany Director3356770001
    BANDEL, Martin Howard
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant37249220002
    EDWARDS, Dylan Crocker
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    Amministratore
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    BritishRetired Banker5965630001
    GLOVER, Edward Douglas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritishMerchant Banker121380002
    GLOVER, Edward Douglas
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    Amministratore
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    United KingdomBritishMerchant Banker121380002
    RAWLINS, Richard Denis
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    Amministratore
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    United KingdomBritishSurveyor56889050001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Amministratore
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    BritishChartered Accountant5463920001
    SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    Amministratore
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    United KingdomBritishCompany Director76573230001

    MATLODGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 lug 1996
    Consegnato il 31 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 27 set 1990
    Consegnato il 05 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 07 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First second and third floors at 150 old brompton road london SW7. Floating charge over all machinery implements utensils, furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1985
    Consegnato il 28 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17, waterloo place, leamington, warwickshire and parway house, 202/204 finchley road, london borough of camden.
    Persone aventi diritto
    • Central Properties (Southern Counties) Limited.
    Transazioni
    • 28 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 19 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ago 1984
    Consegnato il 20 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    105, old brompton road, royal borough of kensington and chelsea. Fixed & floating charge over all fixtures, fittings plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Japhet PLC.
    Transazioni
    • 20 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1984
    Consegnato il 27 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 29 philbeach gardens, london SW5. Title no: ln 73637 fixed & floating charge over all fixtures, fittings plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 gen 1983
    Consegnato il 19 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 37 courtfield road, in the royal borough of kensington and chelsea.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1981
    Consegnato il 12 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £ 2,050,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/Hold property 62-86 (even nos) old brompton rd, london SW7 title no. Ngl 322169. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Central Associates (Southern Countries) LTD
    Transazioni
    • 12 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 19 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1981
    Consegnato il 07 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000
    Brevi particolari
    F/H land fronting bulwark road, chepstow, monmouthshire, f/h land fronting ely valley road, and talbot green, glamorgan. F/h 65-71, (odd nos) the cut, london SE1. F/h rylands buildings, market street, manchester. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Central Properties (Southern Counties) Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 19 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1980
    Consegnato il 16 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Parway house, 202/204 finchley road, camden title ln 234626.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullman Limited
    Transazioni
    • 16 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1980
    Consegnato il 08 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5, 21, 25, 37 and 41 circus lodge, circus road london N.W.8.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullmann Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1980
    Consegnato il 08 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6, 9, 12, 15, 17, 24, 103, 106, 109, 111, 122, 123, 125, 209, 210, 216, 221, 222, 302, 303, 304, 309, 313, 315, 316, 317, 320, 402, 404, 411, 413, 417, 418 and 419 addison house grove end rd london NW8.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullmann Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1980
    Consegnato il 08 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34/35 36, 38, 40, 42, 53, 56, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 86, 87/88, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 106, 114, 117 and 118 abbey house abbey road london NW8.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullmann Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1980
    Consegnato il 08 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5, 6, 104, 106, 207, 302, 403, 405, 409 and 410 elm area court, elm tree road london NW8.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullmann Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1979
    Consegnato il 03 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,927,311.58
    Brevi particolari
    F/H property 1-17 maroon place 93, 114 & 116 queens gate and 5-8 reece mews london S.W7 title no. Ngl 219499.
    Persone aventi diritto
    • Ridgeland Properties Limited
    Transazioni
    • 03 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1978
    Consegnato il 06 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    93 & 99 queensgate, london SW7. 114, 115 & 116 queensgate london SW7. 1/17 marion place, london SW7. 3/8 reece mews, london S.W.7 62/86 old brampton rd, london S.W.M. together with plant machinery fixtures implements and untensils.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullmann Limited.
    Transazioni
    • 06 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge effecting substitution of security.
    Creato il 29 nov 1976
    Consegnato il 09 dic 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £550,000 and all other monies due secured by a charge dated 16/10/64 & deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Rylands buildings market st.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 09 dic 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 1974
    Consegnato il 04 ott 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever floater
    Brevi particolari
    Various properties set out in the attached schedule marked "a" and "b". See doc m 62 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Keyser Ullmann LTD
    Transazioni
    • 04 ott 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 27 ago 1974
    Consegnato il 29 ago 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principal deed dated 16-10-64 & deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Various properties as shown on the schedule attached to document no M61.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 29 ago 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0