CROMWELL LAND LIMITED

CROMWELL LAND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCROMWELL LAND LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00989850
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CROMWELL LAND LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CROMWELL LAND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CROMWELL LAND LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CROMWELL LAND SECURITIES LIMITED06 dic 199006 dic 1990
    CROMWELL LAND SECURITY LIMITED19 nov 199019 nov 1990
    CITYLAND PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED15 feb 198915 feb 1989
    CITYLAND HOTELS LIMITED22 set 197022 set 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di CROMWELL LAND LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CROMWELL LAND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Stato del capitale al 11 ott 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 23 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 feb 2016

    Stato del capitale al 24 feb 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 54 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 53 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 52 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Iain Douglas Bond come amministratore in data 30 nov 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2015

    Stato del capitale al 12 gen 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Varie

    Aud res sec 519
    1 pagineMISC

    Varie

    Sect 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2014

    Stato del capitale al 10 gen 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Sharon Kerridge come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CROMWELL LAND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WYLLIE, Alison
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Segretario
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    British107811220001
    HUXTABLE, Christopher John
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Banker156351910001
    THORP, Timothy Geoffrey
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    EnglandBritishChartered Accountant66923730003
    BANDEL, Martin Howard
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary37249220002
    COLE, Jennifer
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    Segretario
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    British74489480002
    FORSTER, Helen
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    Segretario
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    British106129360001
    JENKINSON, Louisa Jane
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    Segretario
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    British106060330002
    LYON, Karen
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Other140536930001
    MILLER, Philip
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    Segretario
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    British121053850001
    POOLE, Rebecca Louise
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    Segretario
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    British92013940001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Segretario
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    British5463920001
    PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    Segretario
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    76827740001
    ALLPORT, Howard Coplestone
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    Amministratore
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    BritishCo Director3356770001
    BANDEL, Martin Howard
    Flat 6
    1/2 Alma Square St Johns Wood
    NW8 9QD London
    Amministratore
    Flat 6
    1/2 Alma Square St Johns Wood
    NW8 9QD London
    BritishChartered Accountant37249220003
    BOND, Iain Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United KingdomBritishProperty Director68687180001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Amministratore
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishGroup Accountant84225840001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    12 Cherry Close
    SM5 2BW Carshalton
    Surrey
    Amministratore
    12 Cherry Close
    SM5 2BW Carshalton
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Accountant84225840001
    EDWARDS, Dylan Crocker
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    Amministratore
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    BritishSurveyor5965630001
    GLEDHILL, Sarah Louise
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant131963100002
    GLOVER, Edward Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishMerchant Banker121380002
    HAYES, Laurence Edwin
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Amministratore
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishAccountant192784770001
    HOLBROOK, Carolyn
    5 Croftside
    CO8 5LL Bures St Mary
    Suffolk
    Amministratore
    5 Croftside
    CO8 5LL Bures St Mary
    Suffolk
    United KingdomBritishProperty Management165098780001
    KERRIDGE, Sharon Diana Mandy
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker128267610003
    MOFFAT, Andrew David John
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Amministratore
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    EnglandBritishMerchant Banker34399870003
    RAWLINS, Richard Denis
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    Amministratore
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    United KingdomBritishSurveyor56889050001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Amministratore
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    BritishAccountant5463920001
    SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    Amministratore
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    United KingdomBritishCompany Director76573230001
    THORP, Timothy Geoffrey
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant66923730003

    CROMWELL LAND LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over bank accounts
    Creato il 21 giu 2011
    Consegnato il 30 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the charged balance and charged accounts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 giu 2011
    Consegnato il 22 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Raglan court empire way wembley t/n P137078, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2011
    Consegnato il 22 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Flat 8 raglan court empire way wembley t/n NGL782443, flat 19 raglan court empire way wembley t/n NGL782442, flat 20 raglan court empire way wembley t/n NGL782441, for details of further properties charged, please refer to form MG01, together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, the goodwill of any business carried on at the property, the benefit of all licences & registration required in the running of such a business (see image for full details).
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 lug 1996
    Consegnato il 31 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1996
    Consegnato il 12 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land situated at 3, 5 and 7 whitegate road and 2, 4 and 6 warrior square, southend on sea t/no. EX171106 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    49 atlanta street, fulham, together with the benefit of all rights licences and covenants affecting the property, fixed charge over all plant and other machinery,fixtures and fittings ,furniture and equipment ,implements and utensils etc... the present and future goodwill of any business carried on at or about the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge.
    Creato il 30 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6 to 18 tudor court , russell hill. Purley,croydon. London together with all covenants and rightrs affecting or concerning the property , the plant and machinery and fixtures and fittings furniture, equipment implements and utensils, of the company now and in the future at the property ,the present and future goodwill of any business carried on at or about the property. Please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge.
    Creato il 30 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 to 66 kensington mansions, trebovir road, kensington and chelsea, together with the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property , all plant and other machinery fixtures and fittings ,furniture equipment ,implements and utensils. The present and future goodwill of any business carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 to 10A purley parade ,(excluding no .3 ) high street, purley. Fixed charge over all covenants and rights affecting or concerning the property, the plant ,machinery , and fixtures and fittings ,furniture, equipment ,implements utensils,of the company now and in the future at the property. The present and future goodwill of the business carried on at the property .
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 27 set 1990
    Consegnato il 05 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of evendate.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1988
    Consegnato il 30 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    141, finborough road, london SW10. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 30 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1988
    Consegnato il 16 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    91, bere hill crescent, andover, hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 16 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1988
    Consegnato il 22 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First and fixed legal charge over property k/as 67 penge road london SE 25.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1988
    Consegnato il 03 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge 103A westbourne grove london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 03 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 feb 1988
    Consegnato il 23 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H courtfield rd london SW7 t/no ngl 599654 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Swordheath Properties Limited
    Transazioni
    • 23 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1988
    Consegnato il 02 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over:- 3 north street, horsham west sussex and,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1987
    Consegnato il 04 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 30, downland place, adastral road, canford heath, poole, dorset title no: dt 105678 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 04 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge registered pursuant to a statutory declaration dated 11/9/87
    Creato il 18 ago 1987
    Consegnato il 03 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-69 denmark hill, camberwell, london SE5 T.no:- sgl 279325. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 03 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1987
    Consegnato il 09 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    42, finborough rd; london SW10. Floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 09 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1987
    Consegnato il 08 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    106 church rd, richmond surrey floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 gen 1987
    Consegnato il 07 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 37, courtfield road, london SW7 title no ngl 455035 inc fixtures fittings plant, machinery, implements,utensils furniture & equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 07 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1986
    Consegnato il 06 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat e, angel house, pentonville road, london N1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1986
    Consegnato il 28 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property 338 south norwood hill, london SE25 and floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1986
    Consegnato il 10 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 4, 15 whitworth road, london SE25.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1986
    Consegnato il 10 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    41 ronelean road, folworth r b of kingston upon thames.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0