THE COLONY CLUB LIMITED

THE COLONY CLUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE COLONY CLUB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00990697
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE COLONY CLUB LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE COLONY CLUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE COLONY CLUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTERNATIONAL SPORTING CLUB (LONDON) LIMITED01 ott 197001 ott 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE COLONY CLUB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per THE COLONY CLUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Genting Club Star City Watson Road Birmingham B7 5SA a One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH in data 09 ott 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 set 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Notifica di Capital Casinos Group Limited come persona con controllo significativo il 07 ago 2017

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 07 ago 2017

    2 paginePSC09

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    1 pagineAA

    Nomina di Mr James Axelby come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Malcolm Brooks il 24 mag 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Paul Stewart Willcock come amministratore in data 23 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Robert Salmond come amministratore in data 23 dic 2015

    1 pagineTM01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    27 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ott 2015

    Stato del capitale al 19 ott 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    1 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Jill Tarn il 23 ott 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2014

    Stato del capitale al 20 ott 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ott 2013

    Stato del capitale al 11 ott 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di THE COLONY CLUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TARN, Elizabeth Jill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Segretario
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    British131467900001
    AXELBY, James
    Star City, Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club
    England
    Amministratore
    Star City, Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club
    England
    United KingdomBritish210535950001
    BROOKS, Peter Malcolm
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Amministratore
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    MonacoBritish84067460002
    WILLCOCK, Paul Stewart
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Amministratore
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    EnglandBritish206400610001
    BARKER, Nicholas Charles Lawrence
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    British10939990001
    CHANDLER, Andrew Philip
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    Segretario
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    British53832740002
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Segretario
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    GOULBOURNE, Sarah-Jane
    36 Wynnstay Lane
    Marford
    LL12 8LG Wrexham
    Clwyd
    Segretario
    36 Wynnstay Lane
    Marford
    LL12 8LG Wrexham
    Clwyd
    British64347190002
    MOORE, Gillian
    13 Basil Way
    South Shields
    NE34 8UA Tyne And Waer
    Segretario
    13 Basil Way
    South Shields
    NE34 8UA Tyne And Waer
    British113027650001
    PEREIRA, Desmond Cajetan
    Manor Villas 161g Station Road
    Finchley Central
    N3 2SP London
    Segretario
    Manor Villas 161g Station Road
    Finchley Central
    N3 2SP London
    British108086000001
    BARKER, Nicholas Charles Lawrence
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    British10939990001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Amministratore
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    CHANDLER, Andrew Philip
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    Amministratore
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    United KingdomBritish53832740002
    CHILD, Colin Charles
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    Amministratore
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    EnglandBritish125146440001
    DUNKLEY, John David
    29 Burnett Park
    CM19 4SD Harlow
    Essex
    Amministratore
    29 Burnett Park
    CM19 4SD Harlow
    Essex
    British24899280001
    GRAY, David William
    15 Huson Close
    NW3 3JW London
    Amministratore
    15 Huson Close
    NW3 3JW London
    EnglandBritish78691870001
    HEARN, Alan John
    Tylecroft 29 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tylecroft 29 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British13648200003
    HOSKINS, Michael
    83 Nelmes Crescent
    RM11 2PR Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    83 Nelmes Crescent
    RM11 2PR Hornchurch
    Essex
    EnglandBritish55577460001
    LOWRY, Thomas Allen
    Homewood
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    Amministratore
    Homewood
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    EnglandBritish34909450002
    MCNALLY, Peter
    Silver Lining
    Brock Way
    GU25 4SD Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Silver Lining
    Brock Way
    GU25 4SD Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish24036040001
    NESBITT, Garry
    5 Frognal Way
    Hampstead
    NW3 6XE London
    Amministratore
    5 Frognal Way
    Hampstead
    NW3 6XE London
    British10940020001
    PERRIN, Nicholas John
    Henley Road
    B95 5NN Ullenhall
    Treboro House
    Warwickshire
    Amministratore
    Henley Road
    B95 5NN Ullenhall
    Treboro House
    Warwickshire
    EnglandBritish174660810001
    QUINLAN, Timothy Edward
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritish49553030001
    RAHA, Maryse
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    French24036050001
    RIDDY, Alan Michael
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    Amministratore
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    EnglandBritish62615300004
    RIDDY, Alan Michael
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    Amministratore
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    EnglandBritish62615300004
    SALMOND, Richard Robert
    Star City
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Circus Casino
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Star City
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Circus Casino
    West Midlands
    England
    EnglandBritish164973490001
    STEINBERG, Leonard, Lord
    20 Carrwood
    Halebarns
    WA15 0EE Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    20 Carrwood
    Halebarns
    WA15 0EE Altrincham
    Cheshire
    British35686260002
    WIPER, Robert
    The Hollow
    Moggie Lane
    SK10 4NY Adlington
    Cheshire
    Amministratore
    The Hollow
    Moggie Lane
    SK10 4NY Adlington
    Cheshire
    United KingdomBritish73690420002
    WIPER, Robert
    Pelham Cottage
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Cheshire
    Amministratore
    Pelham Cottage
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Cheshire
    British73690420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE COLONY CLUB LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club Star City
    England
    07 ago 2017
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club Star City
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02321709
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE COLONY CLUB LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    23 set 201607 ago 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    THE COLONY CLUB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental guarantee and debenture
    Creato il 24 dic 1997
    Consegnato il 08 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of capital corporation (holdings) limited and/or crockfords club limited and/or the company to midland bank PLC under the midland overdraft facility (as defined) and of cromwell sporting enterprises limited to national westminster bank PLC under the natwest overdraft facility (as defined) and of each obligor (as defined) due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined) and of each obligor due or to become due to the chargee and/or the banks (as defined) or any of them under any other financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Agent")
    Transazioni
    • 08 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 18 dic 1995
    Consegnato il 04 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present or future obligations and liabilities of the company to the chargees pursuant to the terms of the 364-day facility the security and financing documents (as defined) and/or this supplemental debenture
    Brevi particolari
    All the property (if any ) specified in the first schedule to the original guarantee and debenture together with all buildings and fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for the Revolving Credit Banks and the Overdraft Bank (Asdefined)
    Transazioni
    • 04 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 ago 1995
    Consegnato il 15 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from crockfords (holdings) limited to the chargee and/or the revolving credit banks (or any of them) under the facility agreement dated 11 october 1994 (as defined) and all monies due or to become due from crockfords (holdings) limited and/or crockfords club limited to the overdraft bank under the overdraft facility agreement dated 11 october 1994 (as defined) and all monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and/or the banks (or any of them) under the security document(s) or any other financing document(s) (as defined) to which it is a party
    Brevi particolari
    An underlease dated 1994 and relating to casino premises at 18-19 old park land and 24 hertford street london W1 t/n NGL726210, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and for the Revolving Credit Banks and the Overdraft Bank (As Defined)
    Transazioni
    • 15 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 11 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The William Hill Group Limited
    Transazioni
    • 11 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 mar 1992
    Consegnato il 14 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture.
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The William Hill Group Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 27 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 nov 1991
    Consegnato il 28 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all of the other companies named therein to the chargee under the facility agreement dated 11TH november 1991
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 28 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 lug 1991
    Consegnato il 18 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thebrent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 1ST july 1991
    Brevi particolari
    See doc M150 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 18 lug 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 17 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of this deed to the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M140 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders as Defined)
    Transazioni
    • 17 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from brent walker limited under the terms of the facility agreement dated 19/2/91 and this deed to the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M171 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC under the terms of the stand by facility agreement dated 15/11/90 and this deed to the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of the facility agreement dated 28/3/91 and this deed th the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M125 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE COLONY CLUB LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 set 2018Inizio della liquidazione
    04 set 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicholas James Timpson
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0