DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED

DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00991769
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 dic 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Cullum Capital Ventures Limited come persona con controllo significativo il 14 lug 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom a 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD in data 14 lug 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Antonios Erotocritou come amministratore in data 01 ago 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Diane Cougill come amministratore in data 01 ago 2019

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 1 Minster Court London EC3R 7AA in data 30 lug 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dean Clarke come segretario in data 11 dic 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 11 dic 2018

    1 pagineTM02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 03 ago 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 03 ago 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Antonios Erotocritou come amministratore in data 02 mar 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253940410001
    COUGILL, Diane
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Finance Officer158614590002
    ROSS, David Christopher
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector222326970001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087760001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221972430001
    MALONEY, Ann
    34 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RJ Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    34 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RJ Altrincham
    Cheshire
    British34000940001
    MALONEY, Elaine
    Whitford House
    Dams Lane, Allostock
    WA16 9JJ Knutsford
    Segretario
    Whitford House
    Dams Lane, Allostock
    WA16 9JJ Knutsford
    BritishSecretary74677110001
    MC GROGGAN, Francis
    The Chestnuts 48 Wardle Road
    M33 3DH Sale
    Cheshire
    Segretario
    The Chestnuts 48 Wardle Road
    M33 3DH Sale
    Cheshire
    IrishAccountant55775370001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183283050001
    AINSBURY, Barry Dennis
    37 Park Road
    Disley
    SK12 2LX Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    37 Park Road
    Disley
    SK12 2LX Stockport
    Cheshire
    BritishInsurance Broker1723230001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Amministratore
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishDirector134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Amministratore
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritishDirector129538180001
    MALONEY, William Francis
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Amministratore
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandIrishInsurance Broker11863380006
    MC GROGGAN, Francis
    The Chestnuts 48 Wardle Road
    M33 3DH Sale
    Cheshire
    Amministratore
    The Chestnuts 48 Wardle Road
    M33 3DH Sale
    Cheshire
    United KingdomIrishAccountant55775370001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishDirector162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector113694470002
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cullum Capital Ventures Limited
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione5587424
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DAWSON PENNINGTON & COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 set 2010
    Consegnato il 18 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 28 apr 2008
    Consegnato il 03 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2008
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1998
    Consegnato il 08 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as 5 holmdale court, northenden road sale cheshire. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 08 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1992
    Consegnato il 01 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £176,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/as 404 barlow moor road chorlton cum hardy manchester M21 2AW t/no gm 39559 f/h property k/as 2 moorside road heaton moor stockport t/no gm 166528.
    Persone aventi diritto
    • William Francis Maloney
    Transazioni
    • 01 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 1992
    Consegnato il 02 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £176,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    2 moorside road heaton moor stockport cheshire SK4 4DT and 404 barlow moor road chorlton cum hardy manchester M21 2AN. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • W Maloney
    Transazioni
    • 02 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1990
    Consegnato il 23 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    404 barlow moor road chorlton cum hardy manchester M21 2AN. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 23 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1990
    Consegnato il 23 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 moorside road heaton moor stockport SK4 4DT. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 23 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 nov 1990
    Consegnato il 23 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 moorside road heston moor stockport SK4 4DT and 404 barlow moor road chorlton cum hardy manchester M21 2AN. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 23 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0