OBL (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOBL (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00996136
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OBL (UK) LIMITED?

    • Attività di gioco d'azzardo e scommesse (92000) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova OBL (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OBL (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DOLDARRA SERVICES LIMITED31 ago 199031 ago 1990
    A.F.M. LEISURE LIMITED31 dic 197631 dic 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di OBL (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 ott 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OBL (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per OBL (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagine4.72

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 apr 2013

    29 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Leisure Connection Ltd Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* in data 27 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Jonathan Dyson come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Low Lane Horsforth Leeds LS18 4ER* in data 03 ago 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 01 ott 2011

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2012

    Stato del capitale al 19 giu 2012

    • Capitale: GBP 661,034
    SH01

    Bilancio redatto al 02 ott 2010

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Derek Lloyd come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Julian Frederick Nicholls come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Matthew Still come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Meehan come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 26 set 2009

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Jonathan Philip Dyson come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 27 set 2008

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Memorandum e Statuto

    5 pagineMEM/ARTS

    legacy

    13 pagine155(6)a

    Chi sono gli amministratori di OBL (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant71581460002
    NICHOLLS, Julian Frederick
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishNone95086050001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector71581460002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector1278190001
    DYSON, Jonathan Philip
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra
    West Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra
    West Yorkshire
    United KingdomBritishNone150340570001
    EVANS, Wayne David
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    United KingdomBritishChartered Accountant118359700001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant35569170001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector71715970001
    LLOYD, Derek Thomas
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    Amministratore
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishDirector98695040001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector130608590001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant142125320001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Amministratore
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    BritishEngineer809230004
    WELL, Raymond
    30a East End
    Walkington
    HU17 8RY Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    30a East End
    Walkington
    HU17 8RY Beverley
    North Humberside
    BritishCompany Director38284430002
    WELLS (JNR), Raymond
    1 Lawson Close
    Walkington
    HU17 8TR Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    1 Lawson Close
    Walkington
    HU17 8TR Beverley
    North Humberside
    BritishCompany Director38284430001

    OBL (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 19 ago 2008
    Consegnato il 21 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch (Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002 and
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and/or the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK588050 and f/h property k/a miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK48128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 21 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all that freehold property known as main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK588050. All that freehold property known as miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK48128, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ott 1992
    Consegnato il 21 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in "the debenture"
    Brevi particolari
    See doc ref M557C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcin Its Capacity as Agent and Trustee for Itselfand Each of the Banks
    Transazioni
    • 21 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and trust debenture
    Creato il 06 mar 1991
    Consegnato il 20 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security document (as defined)
    Brevi particolari
    Various properties as defined in form 395 reg M96.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    • (For Itsle National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 20 giu 1984
    Consegnato il 03 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £24,574.61 & agreed interest of £3,945.39 due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 20-6-8
    Brevi particolari
    Name of ship - "etanche" official no-397233 part of registry - yarmouth no 13 in 1981.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    Transazioni
    • 03 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Marine mortgage
    Creato il 20 giu 1984
    Consegnato il 03 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the charge on an account current under the terms of a deed dated 20/6/84
    Brevi particolari
    Ship - "entanche" official no- 397233 part of regentry - yarmouth no 13 in 1981.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    Transazioni
    • 03 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Agreement
    Creato il 01 mag 1982
    Consegnato il 20 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £228,405.
    Brevi particolari
    Motor vehicles whose registration numbers are as shown on document M31.
    Persone aventi diritto
    • Marley Vehicle Leasing Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 30 gen 1981
    Consegnato il 04 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific & equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    OBL (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    03 apr 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    03 apr 2013Inizio della liquidazione
    04 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0