KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED

KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKINGSWOOD FLUID POWER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00996228
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KINGSWOOD (HYDRAULICS) LIMITED07 dic 197007 dic 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    GAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 lug 2013

    • Capitale: GBP 555,567
    4 pagineSH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per David White il 26 set 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Martyn Richard Powell il 26 set 2012

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    9 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    9 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    POWELL, Martyn Richard
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Segretario
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    British38707060002
    WHITE, David
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    Amministratore
    Amber Way
    Halesowen
    B62 8WG West Midlands
    United KingdomBritish1596440002
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    LYNE, Colin Andrew
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    Segretario
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    British49615160001
    PROPHET, Ian David
    15 Kingsleigh Gardens
    BS15 2FG Bristol
    Segretario
    15 Kingsleigh Gardens
    BS15 2FG Bristol
    British49931320001
    THOMAS, Stephen Paul
    17 Bell Barn Road
    Stoke Bishop
    BS9 2DA Bristol
    Avon
    Segretario
    17 Bell Barn Road
    Stoke Bishop
    BS9 2DA Bristol
    Avon
    British5481200001
    WINTERS, Geoffrey David
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    Segretario
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    British42524380002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    11 Walker Street
    EH3 7NE Edinburgh
    Segretario
    11 Walker Street
    EH3 7NE Edinburgh
    38777080001
    BANNISTER, David
    38a Southport Road
    Lydiate
    L31 2HZ Liverpool
    Amministratore
    38a Southport Road
    Lydiate
    L31 2HZ Liverpool
    British47814280001
    BROWN, Martin Leonard
    18 The Downs
    Portishead
    BS20 8AT Bristol
    Avon
    Amministratore
    18 The Downs
    Portishead
    BS20 8AT Bristol
    Avon
    British11496710001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    DIXON, Mark Robert Graham
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    Amministratore
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    United KingdomBritish51467220003
    DIXON, Mark Robert Graham
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    Amministratore
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    United KingdomBritish51467220003
    GARETY, Christopher Francis
    Banks Barn Dunsop Road
    Newton In Bowland
    BB7 3ED Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Banks Barn Dunsop Road
    Newton In Bowland
    BB7 3ED Clitheroe
    Lancashire
    British62171720001
    HILL, David Graham
    Briar Cottage
    Court Lane, Wick
    BS30 5RB Bristol
    Avon
    Amministratore
    Briar Cottage
    Court Lane, Wick
    BS30 5RB Bristol
    Avon
    British70177360001
    JOHNSON, Richard Stuart
    Braxfield House
    Charingworth
    GL55 6XU Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Braxfield House
    Charingworth
    GL55 6XU Chipping Campden
    Gloucestershire
    British6420800001
    LINK, Alan Wilfred
    64 Aldridge Road
    Little Aston
    B74 3TS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    64 Aldridge Road
    Little Aston
    B74 3TS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British81243590001
    LYNE, Colin Andrew
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    Amministratore
    The Haven
    Featherbed Lane Pathlow
    CV37 0ER Stratford
    Warwickshire
    United KingdomBritish49615160001
    MACKIE, Brian Wilbert
    17 Burnside Close
    SK9 1EL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    17 Burnside Close
    SK9 1EL Wilmslow
    Cheshire
    British93526270001
    MORRIS, Anthony Nigel
    42 Alrewas Road
    Kings Bromley
    DE13 7HW Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    42 Alrewas Road
    Kings Bromley
    DE13 7HW Burton On Trent
    Staffordshire
    British39324790001
    PARSONAGE, Simon John
    2 Ash Close
    Brooklands Park
    SY7 9RL Craven Arms
    Salop
    Amministratore
    2 Ash Close
    Brooklands Park
    SY7 9RL Craven Arms
    Salop
    British50531790001
    STUBBS, David Steven
    124 Oxford Road
    Stratton St Margaret
    SN3 4HD Swindon
    Amministratore
    124 Oxford Road
    Stratton St Margaret
    SN3 4HD Swindon
    British5481210002
    THOMAS, Stephen Paul
    17 Bell Barn Road
    Stoke Bishop
    BS9 2DA Bristol
    Avon
    Amministratore
    17 Bell Barn Road
    Stoke Bishop
    BS9 2DA Bristol
    Avon
    British5481200001
    WESTON, John
    11 Lupin Close
    Whittle Le Woods
    PR6 7RG Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    11 Lupin Close
    Whittle Le Woods
    PR6 7RG Chorley
    Lancashire
    British47814160002
    WINTERS, Geoffrey David
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    Amministratore
    Tavistock House
    Mearse Lane
    B45 8HL Barnt Green
    Worcester
    British42524380002

    KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge and accession
    Creato il 07 mar 2002
    Consegnato il 21 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries and/or the mezzanine security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 nov 1988
    Consegnato il 24 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 giu 1987
    Consegnato il 16 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units a, b & C. avondale works woodland way kingswood in avon part of t/no bl 8689.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 1980
    Consegnato il 24 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 4/4 speedwell road, kingswood bristol, avon. Title no bl 26348.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 24 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 feb 1980
    Consegnato il 04 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including, goodwill uncalled capital, bookdebts all buildings fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 04 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KINGSWOOD FLUID POWER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 ago 2013Inizio della liquidazione
    12 ago 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0