SIG PLC
Panoramica
Nome della società | SIG PLC |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società per azioni |
Numero di società | 00998314 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SIG PLC?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SIG PLC?
Indirizzo della sede legale | Adsetts House 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SIG PLC?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SHEFFIELD INSULATIONS GROUP PLC | 20 apr 1989 | 20 apr 1989 |
SHEFFIELD INSULATING COMPANY LIMITED(THE) | 29 dic 1970 | 29 dic 1970 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SIG PLC?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SIG PLC?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 16 lug 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 30 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 16 lug 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SIG PLC?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iscrizione dell'ipoteca 009983140006, creata il 25 ott 2024 | 39 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023 | 212 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022 | 226 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Mr Diego Straziota come amministratore in data 04 mag 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Christian Pierre Rochat come amministratore in data 04 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Ronald Francis come amministratore in data 01 feb 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Mr Gavin Slark come amministratore in data 01 feb 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Kathryn Louise Durrant il 15 lug 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021 | 235 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Pierre Rochat il 16 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Charles Lovell il 16 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Kathryn Louise Durrant il 16 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Theodore King il 16 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Ian Ashton il 16 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bruno Marc Deschamps il 16 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Andrew Watkins il 16 mar 2022 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 009983140005, creata il 18 nov 2021 | 39 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2020 | 240 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||
Stato del capitale al 24 giu 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SIG PLC?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATKINS, Andrew | Segretario | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | 281611780001 | |||||||
ALLNER, Andrew James | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 239699110002 | ||||
ASHTON, Richard Ian | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 271608130002 | ||||
DASANI, Shatish Damodar | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | Company Director | 132555670003 | ||||
DESCHAMPS, Bruno Marc | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | French | Company Director | 141839570001 | ||||
DURRANT, Kathryn Louise | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 321333540002 | ||||
KENT, Gillian Dawn Celia | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 257031700001 | ||||
KING, Simon Theodore | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | Company Director | 220935360001 | ||||
LOVELL, Alan Charles | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | Company Director | 149625410005 | ||||
SLARK, Gavin | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Group Chief Executive Officer | 162972090002 | ||||
STRAZIOTA, Diego | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 238012210001 | ||||
DOSANJH, Kulbinder Kaur | Segretario | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | 263757070001 | |||||||
MONRO, Richard Charles | Segretario | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
PRUST, Francis Charles | Segretario | Peverill 25 Wharfe Bank LS22 5JP Collingham West Yorkshire | British | 54280001 | ||||||
SWYNNERTON, John Ralph | Segretario | 30 Bents Road S11 9RJ Sheffield South Yorkshire | British | 2646260001 | ||||||
ABT, Andrea | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | Germany | German | Non-Executive Director | 195779450002 | ||||
ADSETTS, William Norman, Sir | Amministratore | 28 Endcliffe Hall Avenue S10 3EL Sheffield South Yorkshire | British | Director | 54290001 | |||||
ALLUM, Helen Catherine | Amministratore | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | Scotland | British | Company Director | 80472920003 | ||||
ASHDOWN, Janet Elizabeth | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Non-Executive Director | 115126780001 | ||||
BLACKBURN, Peter Hugh | Amministratore | Watersmeet 12 Promenade Square HG1 2PH Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Director | 70564230002 | ||||
BORLENGHI, Michael John Christopher | Amministratore | The Covert School Lane Warmington OX17 1DD Banbury Oxfordshire | British | Business Consultant | 17674110003 | |||||
CHIVERS, Michael John | Amministratore | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 59555980002 | ||||
COTTINGHAM, Barrie | Amministratore | Yew Tree House 1 Old Mount Farm WF4 2LD Woolley West Yorkshire | British | Accountant | 36113910004 | |||||
DAVIES, Christopher John | Amministratore | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 119227540001 | ||||
DAVIES, Gareth Wyn | Amministratore | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | Finance Director | 109674760001 | ||||
DUNCAN, Ian Barnet | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 155565020002 | ||||
EWELL, Melvyn | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Non-Executive Director | 162577330002 | ||||
FORRESTER, William Wilson | Amministratore | Coombs Hay 16 Burre Close DE45 1GD Bakewell Derbyshire | England | British | Managing Director | 27743040001 | ||||
FRANCIS, Stephen Ronald William | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 205102630002 | ||||
GEOGHEGAN, Christopher Vincent | Amministratore | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | Non-Executive Director | 71036100001 | ||||
HAXBY, David Arthur | Amministratore | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 45027450002 | ||||
KEARNEY-CROFT, Katharina Helen Marie | Amministratore | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | England | British | None | 291529900001 | ||||
KENT, David James | Amministratore | 3 Old Hall Clough Lostock BL6 4LB Bolton Lancashire | British | Company Director | 14720610001 | |||||
KITSON, Timothy Peter Geoffrey, Sir | Amministratore | Ulshaw Farm Middleham DL8 4PU Leyburn North Yorkshire | British | Company Director | 2761930002 | |||||
MADDOCK, Nicholas William | Amministratore | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | Company Director | 171817240004 |
SIG PLC ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 25 ott 2024 Consegnato il 29 ott 2024 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 18 nov 2021 Consegnato il 24 nov 2021 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment and charge of rights issue proceeds | Creato il 02 giu 1993 Consegnato il 04 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement and the deed | |
Brevi particolari All the company's right title interest and entitlement to receive monies arising from the subscription for new ordinary shares pursuant to the rights issue. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 19 dic 1984 Consegnato il 04 gen 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north east side of langsett road, sheffield, south yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Title no syk 189567. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental charge | Creato il 18 feb 1983 Consegnato il 23 feb 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the principal deed dated 25/2/77 | |
Brevi particolari By way, of sepecific charge all book & other debts due or owing to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 19 mar 1982 Consegnato il 29 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture 23/10/72 | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book & other debts as are now or may from time to time be owing to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0