SIG PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSIG PLC
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00998314
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di SIG PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SIG PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Adsetts House 16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SIG PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHEFFIELD INSULATIONS GROUP PLC 20 apr 198920 apr 1989
    SHEFFIELD INSULATING COMPANY LIMITED(THE)29 dic 197029 dic 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di SIG PLC?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SIG PLC?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al16 lug 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma30 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al16 lug 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per SIG PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Iscrizione dell'ipoteca 009983140006, creata il 25 ott 2024

    39 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023

    212 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzioni

    Authority to make market purchases 02/05/2024
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzioni

    That a general meeting of the company, other than an annual general meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. 04/05/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022

    226 pagineAA

    Nomina di Mr Diego Straziota come amministratore in data 04 mag 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Pierre Rochat come amministratore in data 04 mag 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Ronald Francis come amministratore in data 01 feb 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Gavin Slark come amministratore in data 01 feb 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Kathryn Louise Durrant il 15 lug 2022

    2 pagineCH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021

    235 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Pierre Rochat il 16 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Charles Lovell il 16 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Kathryn Louise Durrant il 16 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Theodore King il 16 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Ian Ashton il 16 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bruno Marc Deschamps il 16 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Andrew Watkins il 16 mar 2022

    1 pagineCH03

    Iscrizione dell'ipoteca 009983140005, creata il 18 nov 2021

    39 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2020

    240 pagineAA

    Stato del capitale al 24 giu 2021

    • Capitale: GBP 118,155,697.7
    3 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di SIG PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATKINS, Andrew
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Segretario
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    281611780001
    ALLNER, Andrew James
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director239699110002
    ASHTON, Richard Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director271608130002
    DASANI, Shatish Damodar
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director132555670003
    DESCHAMPS, Bruno Marc
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandFrenchCompany Director141839570001
    DURRANT, Kathryn Louise
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director321333540002
    KENT, Gillian Dawn Celia
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director257031700001
    KING, Simon Theodore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director220935360001
    LOVELL, Alan Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director149625410005
    SLARK, Gavin
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Chief Executive Officer162972090002
    STRAZIOTA, Diego
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director238012210001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Segretario
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    263757070001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Segretario
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    British59480370001
    PRUST, Francis Charles
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    Segretario
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    British54280001
    SWYNNERTON, John Ralph
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    British2646260001
    ABT, Andrea
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    GermanyGermanNon-Executive Director195779450002
    ADSETTS, William Norman, Sir
    28 Endcliffe Hall Avenue
    S10 3EL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    28 Endcliffe Hall Avenue
    S10 3EL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector54290001
    ALLUM, Helen Catherine
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director80472920003
    ASHDOWN, Janet Elizabeth
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishNon-Executive Director115126780001
    BLACKBURN, Peter Hugh
    Watersmeet
    12 Promenade Square
    HG1 2PH Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Watersmeet
    12 Promenade Square
    HG1 2PH Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director70564230002
    BORLENGHI, Michael John Christopher
    The Covert
    School Lane Warmington
    OX17 1DD Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Covert
    School Lane Warmington
    OX17 1DD Banbury
    Oxfordshire
    BritishBusiness Consultant17674110003
    CHIVERS, Michael John
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director59555980002
    COTTINGHAM, Barrie
    Yew Tree House
    1 Old Mount Farm
    WF4 2LD Woolley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Tree House
    1 Old Mount Farm
    WF4 2LD Woolley
    West Yorkshire
    BritishAccountant36113910004
    DAVIES, Christopher John
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director119227540001
    DAVIES, Gareth Wyn
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director109674760001
    DUNCAN, Ian Barnet
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director155565020002
    EWELL, Melvyn
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishNon-Executive Director162577330002
    FORRESTER, William Wilson
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritishManaging Director27743040001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director205102630002
    GEOGHEGAN, Christopher Vincent
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritishNon-Executive Director71036100001
    HAXBY, David Arthur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director45027450002
    KEARNEY-CROFT, Katharina Helen Marie
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishNone291529900001
    KENT, David James
    3 Old Hall
    Clough Lostock
    BL6 4LB Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    3 Old Hall
    Clough Lostock
    BL6 4LB Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director14720610001
    KITSON, Timothy Peter Geoffrey, Sir
    Ulshaw Farm
    Middleham
    DL8 4PU Leyburn
    North Yorkshire
    Amministratore
    Ulshaw Farm
    Middleham
    DL8 4PU Leyburn
    North Yorkshire
    BritishCompany Director2761930002
    MADDOCK, Nicholas William
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director171817240004

    SIG PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 ott 2024
    Consegnato il 29 ott 2024
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 29 ott 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 nov 2021
    Consegnato il 24 nov 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 24 nov 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of assignment and charge of rights issue proceeds
    Creato il 02 giu 1993
    Consegnato il 04 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement and the deed
    Brevi particolari
    All the company's right title interest and entitlement to receive monies arising from the subscription for new ordinary shares pursuant to the rights issue. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 04 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 dic 1984
    Consegnato il 04 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side of langsett road, sheffield, south yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Title no syk 189567. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge
    Creato il 18 feb 1983
    Consegnato il 23 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the principal deed dated 25/2/77
    Brevi particolari
    By way, of sepecific charge all book & other debts due or owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • County Banks Limited
    Transazioni
    • 23 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 19 mar 1982
    Consegnato il 29 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture 23/10/72
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book & other debts as are now or may from time to time be owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0