MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED

MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARLON INSURANCE COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00998720
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Surrey
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SKANDIA MARINE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED01 gen 199201 gen 1992
    VESTA (U.K.) INSURANCE COMPANY LIMITED01 gen 197101 gen 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Dissolution by c/order effective 27/07/2017 manual gazette issued
    1 pagineMISC

    Ordinanza giudiziaria

    Diss by c/order eff 27/07/2017 m
    28 pagineOC

    Gazzetta ufficiale finale sciolta per decreto

    pagineGAZ2

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Guildford Business Park Guildford England and Wales GU2 8XG United Kingdom a 3 Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG in data 03 ago 2016

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Avaya House Cathedral Hill Guildford Surrey GU2 7YL a 3 Guildford Business Park Guildford England and Wales GU2 8XG in data 02 ago 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    35 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mar 2016

    Stato del capitale al 16 mar 2016

    • Capitale: USD 23,172,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Steven Roger Western il 30 nov 2015

    2 pagineCH01

    Ridenominazione delle azioni. Stato del capitale 08 set 2015

    • Capitale: USD 23,172,000
    4 pagineSH14

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2015

    Stato del capitale al 01 apr 2015

    • Capitale: GBP 15,448,000
    SH01

    Nomina di Mr Gary Leonard Griffiths come amministratore in data 19 gen 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Patrick Cogavin come amministratore in data 09 set 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    23 pagineAA

    Cessazione della carica di Theo Wilkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 009987200003

    22 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2014

    Stato del capitale al 17 mar 2014

    • Capitale: GBP 15,448,000
    SH01

    Varie

    Court order confiming cross border merger with a/s det kjobenhavnske reassurance compagni on 31/12/13
    3 pagineMISC

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    21 pagineAA

    Varie

    CB01 draft terms of merger
    46 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Theo James Rickus Wilkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEXTALL, Siobhan Mary
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Irish65283470005
    COGAVIN, Patrick Eamon
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish191149500001
    GRIFFITHS, Gary Leonard
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish184390930001
    THOMAS, Clive Paul
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish170854570001
    TURNER, Alan John
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish103211340004
    WESTERN, Steven Roger
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish98436900002
    COPPELL, Helen
    27 Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    Kent
    Segretario
    27 Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    Kent
    British126248740001
    GRANT, Philip James
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    Segretario
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    British34492660002
    TUKE, Eamonn Vincent
    Eden View
    Penshurst Road, Penshurst
    TN11 8HY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Eden View
    Penshurst Road, Penshurst
    TN11 8HY Tonbridge
    Kent
    British29466740001
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    Segretario nominato
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    900023430001
    ALDOUS, Stephen David
    8 The Cedars
    GU1 1YU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    8 The Cedars
    GU1 1YU Guildford
    Surrey
    British103211370001
    ANONSEN, Hans Terje
    Ostre Stiaberget 62
    Godvik N-5074
    Norway
    Amministratore
    Ostre Stiaberget 62
    Godvik N-5074
    Norway
    Norwegian34152530001
    BAMBER, Anthony
    Adstone
    Bildeston Road Combs
    IP14 2JZ Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Adstone
    Bildeston Road Combs
    IP14 2JZ Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritish70181210003
    BERGENSTJERNA, Johan Philip
    Strandvagen 55
    Stockholm Se-11523
    Sweden
    Amministratore
    Strandvagen 55
    Stockholm Se-11523
    Sweden
    Swedish67925020002
    BOWER, William John
    70 Prince George Avenue
    Oakwood
    N14 4SP London
    Amministratore
    70 Prince George Avenue
    Oakwood
    N14 4SP London
    United KingdomBritish28017860001
    BRANDERS, Christina Maria
    11 Isokaari 11 B 27
    FOREIGN Helsinki
    Fi-00200
    Finland
    Amministratore
    11 Isokaari 11 B 27
    FOREIGN Helsinki
    Fi-00200
    Finland
    Finnish102090620002
    BRUVIK, Trygve
    Rotvollen 25
    N-5041 Nordas
    Norway
    Amministratore
    Rotvollen 25
    N-5041 Nordas
    Norway
    Norwegian42547740001
    GRANT, Philip James
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish34492660002
    HALL, Nigel Rodger
    56 Lower Green Road
    KT10 8HD Esher
    Surrey
    Amministratore
    56 Lower Green Road
    KT10 8HD Esher
    Surrey
    United KingdomBritish65284120001
    HESSELMANN, Christian
    Norde Otervegen 7
    Bergen
    N 5045
    Norway
    Amministratore
    Norde Otervegen 7
    Bergen
    N 5045
    Norway
    Norwegian74376070001
    LINDKVIST, Lars Hakan
    18 Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    Surrey
    Amministratore
    18 Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    Surrey
    British36179090001
    MAKI, Kari Sakari
    Ilpoistente 33 B8
    FOREIGN Turku
    20740
    Finland
    Amministratore
    Ilpoistente 33 B8
    FOREIGN Turku
    20740
    Finland
    Finnish83922180001
    NICHOLS, Thomas James
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish129335930001
    NOKES, Gareth Howard John
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandEnglish141023860001
    ODFJELL, Johan Fredrik
    Shipanesveien 318
    Hjellestad 506
    Norway
    Amministratore
    Shipanesveien 318
    Hjellestad 506
    Norway
    Norwegian58974200001
    POYHONEN, Jorma Tapani
    Laurinpojankuja 4b8
    00840 Helsinki
    Finland
    Amministratore
    Laurinpojankuja 4b8
    00840 Helsinki
    Finland
    Finnish67367640001
    RATHKE, Tom
    Roggesvei 66
    N-5062 Bones
    FOREIGN Bergen Norway
    Amministratore
    Roggesvei 66
    N-5062 Bones
    FOREIGN Bergen Norway
    Norwegian37470670001
    ROCKE, David Michael
    11 Meadow Lane
    DV08 Devonshire
    Bermuda
    Amministratore
    11 Meadow Lane
    DV08 Devonshire
    Bermuda
    British123740180002
    STAAF, Per Ove
    6 Courtwood Drive
    TN13 2LR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    6 Courtwood Drive
    TN13 2LR Sevenoaks
    Kent
    Swedish17857340001
    TEPSTAD, Trond Einar
    Kraakeneslia 47
    5152 Boenes
    Norway
    Amministratore
    Kraakeneslia 47
    5152 Boenes
    Norway
    Norwegian65215820001
    VON HERTZEN, Hans Magnus Ake
    Magnus Hagelstamintie 3 D 14
    Kaunianen
    02700
    Finland
    Amministratore
    Magnus Hagelstamintie 3 D 14
    Kaunianen
    02700
    Finland
    Finnish98181940001
    WILKES, Theo James Rickus
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish172126980001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    06 apr 2016
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06239044
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 mag 2014
    Consegnato il 24 mag 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Citibank Europe PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A reinsurance deposit agreement
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 24 nov 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the reinsurance deposit agreement or under any agreement or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies at the date of the reinsurance deposit agreement standing to the credit of:- (a) each reinsurance deposit or other account the account details of which appear in clause 3(a)(i) of the deed or otherwise as may from time to time agreed in writing between the bank and the chargor;(b) any account opened by the bank pursuant to clauses 3(c) or 11(b) of the reinsurance deposit agreement;or any other account referred to in clause 13 of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank,N.A.
    Transazioni
    • 24 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 24 nov 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security agreement,under any agreement or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chargor's rights,title and interest in and to:(i) all securities which are held by,to the order,for the account or under the control or direction of the bank;(ii) all securities which are held by any clearance system on behalf of,for the account of or to the order of the bank;(iii) all rights,benefits and proceeds arising from or in respect of any of the securities referred to in (I) and (ii) above;(iv) all sums of money standing to the credit of any account opened or maintained by the bank for the chargor;and (v) all sums standing to the credit of any account opened or maintained by any clearance system for the chargor.
    Persone aventi diritto
    • Citibank,N.A.
    Transazioni
    • 24 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0