INVESTABLE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINVESTABLE LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00999661
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INVESTABLE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INVESTABLE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Drayton Hall Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    England
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INVESTABLE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAINTENANCE INSULATION LIMITED14 gen 197114 gen 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di INVESTABLE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2012
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per INVESTABLE LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 mag 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 giu 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INVESTABLE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per INVESTABLE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Victoria Anne George come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Indirizzo della sede legale modificato da * Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB* in data 15 mar 2013

    1 pagineAD01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da * 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom* in data 04 ott 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2012

    Stato del capitale al 21 giu 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Christopher Francis Judd come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jeremy Gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Jeremy Philip Gorman come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lucy Turner come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 01 dic 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Cape House 3 Red Hall Avenue Paragon Business Village Wakefield West Yorkshire WF1 2UL* in data 01 dic 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    16 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Dettagli del segretario cambiati per Lucy Finch Turner il 23 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 18 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Anne George il 18 dic 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INVESTABLE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    Singapore
    Apartment 09-03
    039192
    Singapore
    Segretario
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    Singapore
    Apartment 09-03
    039192
    Singapore
    169544760001
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant133976650005
    CONIBEAR, David Phillip
    7 The Cedars
    Tilehurst
    RG31 6JW Reading
    Berkshire
    Segretario
    7 The Cedars
    Tilehurst
    RG31 6JW Reading
    Berkshire
    British52581380002
    CRAIGIE, Claire Louise
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830002
    GORMAN, Jeremy Philip
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    160675350001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishSecretary829660002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Segretario
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Segretario
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    BritishSolicitor99402260002
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Amministratore
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    BritishAccountant131046090001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Amministratore
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    BritishChartered Accountant40873830002
    CONIBEAR, David Phillip
    7 The Cedars
    Tilehurst
    RG31 6JW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    7 The Cedars
    Tilehurst
    RG31 6JW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant52581380002
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830001
    DUXBURY, Brian
    Carr Lea 15 Platting Road
    Lydgate Saddleworth
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    Carr Lea 15 Platting Road
    Lydgate Saddleworth
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    BritishCompany Director32253580001
    GEORGE, Victoria Anne
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Tax Adviser134024500001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant89560440001
    GREEN, Alan
    2 Barmpton Mews
    DL1 3SZ Darlington
    County Durham
    Amministratore
    2 Barmpton Mews
    DL1 3SZ Darlington
    County Durham
    EnglandEnglishCompany Director20442600005
    JACKSON, Francis Keith John
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director15469790001
    NEEDHAM, Michael John
    Egerton Lincoln Road
    Chalfont Heights
    SL9 9TG Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Egerton Lincoln Road
    Chalfont Heights
    SL9 9TG Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director46524850001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant829660002
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    TAYLOR, Keith Denton
    14 Meridian Way Cochrane Park
    NE7 7RU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    14 Meridian Way Cochrane Park
    NE7 7RU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director49054110001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Amministratore
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritishSolicitor99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant16941000001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    INVESTABLE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined)
    Brevi particolari
    Freehold properties, (I) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Creditors
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 1991
    Consegnato il 21 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £350,000
    Brevi particolari
    Floating charge upon all undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Kaefer Isoliertechnik Gmbh & Co Kg
    Transazioni
    • 21 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H soth side of littlebank street,oldham greater manchester. T/n LA349086.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H- northside of littlebank street, oldham greater manchester tn- OL5572.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1984
    Consegnato il 29 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and premises at the junction at carton right street, and wardle street tn ol 6548.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1984
    Consegnato il 29 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a land and buildings to the south east side of moorhey street, oldham, greater manchester tn la 33706.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1984
    Consegnato il 29 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises at 3A moorhey street oltham, greater manchester and 1 and 3 court number one, moorhey street,l oldham greater manchester tn OL6885.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1984
    Consegnato il 29 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at 5 and 7 moorhey street, oldham greater manchester and 2, number one court, oldham greater manchester tn ol 6601.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1984
    Consegnato il 29 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land at the back of 3A moorhey street, oldham greater manchester T.n la 23442.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H & l/h land & premises k/a moorhey street, oldham, greater manchester T.nos- ol 6885 la 23442 ol 6601 ol 6548 la 33706.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 nov 1982
    Consegnato il 05 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 28 mag 1974
    Consegnato il 05 giu 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charg on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INVESTABLE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 mag 2013Data di scioglimento
    14 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0