HANOVER TWO LIMITED

HANOVER TWO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHANOVER TWO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01000668
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HANOVER TWO LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova HANOVER TWO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HANOVER TWO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARK PRODUCTS LIMITED20 ago 198220 ago 1982
    PARK NAVAL ENGINEERING LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    PARK BROS EXPORT LIMITED25 gen 197125 gen 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di HANOVER TWO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 feb 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per HANOVER TWO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Philip Hedley Bowcock come amministratore in data 14 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Terence Douglas come amministratore in data 14 nov 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ago 2011

    Stato del capitale al 15 ago 2011

    • Capitale: GBP 80,800
    SH01

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Philip Hedley Bowcock come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Jayne Fearn come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 25 feb 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Luminar Leisure Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Andrew Marks come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2009

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 28 feb 2008

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 01 mar 2007

    8 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(353)

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 02 mar 2006

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HANOVER TWO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Segretario
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158740350001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Amministratore
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03802937
    152128090001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Segretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    COLLEDGE, David Ingram
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    Segretario
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    British9330890001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Segretario
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Segretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Amministratore
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Amministratore
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    CARTHY, Terence George
    2 St Elmo Park
    Higher Poynton
    SK12 1TN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 St Elmo Park
    Higher Poynton
    SK12 1TN Stockport
    Cheshire
    British58910980001
    COLLEDGE, David Ingram
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish9330890001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    EARNSHAW, Paul David
    2 Acorn Avenue
    Oswaldtwistle
    BB5 3AZ Accrington
    Lancashire
    Amministratore
    2 Acorn Avenue
    Oswaldtwistle
    BB5 3AZ Accrington
    Lancashire
    British9330920001
    GUTTERIDGE, Timothy Roy
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    British6050070003
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    HOLMES, Michael Robert
    31 The Green
    Welbourn
    LN5 0NJ Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    31 The Green
    Welbourn
    LN5 0NJ Lincoln
    Lincolnshire
    British12168280001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    REID, James
    288 St Davids Road North
    FY8 2JX Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    288 St Davids Road North
    FY8 2JX Lytham St Annes
    Lancashire
    British9330910001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WELSH, James Michael
    Thackwoods The Mains
    Giggleswick
    BD24 0AX Settle
    North Yorkshire
    Amministratore
    Thackwoods The Mains
    Giggleswick
    BD24 0AX Settle
    North Yorkshire
    British9330900002
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002

    HANOVER TWO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 feb 1995
    Consegnato il 23 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 18 set 1990
    Consegnato il 04 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from truscott engineering limited to the chargee
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of park products limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of off set
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 11 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balances of credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 11 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 13 ago 1982
    Consegnato il 03 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from T.s forster & sons limited to the chargee on any account whatsover
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 03 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 07 mag 1982
    Consegnato il 27 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from the company and/or all or any of the other companies named therein.
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 27 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 dic 1980
    Consegnato il 04 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £134,000 & all other monies due or to become due from the co to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge over premises west side of ordanance street blackburn. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Drayton Controls (Engineering) LTD
    Transazioni
    • 04 dic 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0