HAVENSTREET LIMITED

HAVENSTREET LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAVENSTREET LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01001557
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAVENSTREET LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HAVENSTREET LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAVENSTREET LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRANS EURO WORLDWIDE MOVERS (UK) LIMITED29 giu 199929 giu 1999
    BRENT PARK MOVERS AND STORAGE LIMITED30 set 199230 set 1992
    TRANS EURO WORLDWIDE MOVERS LIMITED09 set 198509 set 1985
    TRANS-EURO ROAD SERVICES LIMITED03 feb 197103 feb 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAVENSTREET LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per HAVENSTREET LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mag 2021

    3 pagineAA

    Stato del capitale al 24 giu 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2020

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c and capital redemption reserve 11/05/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 set 2021 al 31 mag 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name13 lug 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 12 lug 2018

    RES15

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2016

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2016

    Stato del capitale al 08 gen 2016

    • Capitale: GBP 62,500
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 62,500
    SH01

    Chi sono gli amministratori di HAVENSTREET LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROMER, Timothy Paul
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Segretario
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    New Zealander42939040001
    METHA, Yogesh
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Amministratore
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    United KingdomBritish88858590001
    ROMER, Timothy Paul
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Amministratore
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    United KingdomNew Zealander42939040001
    MCGREAL, Lawrence Edward
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    Segretario
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    British165048490001
    EVANS, Paul John
    Heath Lodge Heath Side
    Hampstead
    NW3 1LB London
    Amministratore
    Heath Lodge Heath Side
    Hampstead
    NW3 1LB London
    United KingdomBritish56591870006
    GRACE, Frank Clayton
    5 Chesterfield Hill
    W1X 7RP London
    Amministratore
    5 Chesterfield Hill
    W1X 7RP London
    British17960860002
    HAMBRIDGE, Neil Edgar
    26 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    Amministratore
    26 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    British39208740001
    MCGREAL, Lawrence Edward
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    Amministratore
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    EnglandBritish165048490001
    PECK, Stewart Kevin
    25 Cedar Close
    SL0 0QX Iver Heath
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Cedar Close
    SL0 0QX Iver Heath
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish93977420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAVENSTREET LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Trans Euro Limited
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Drury Way
    England
    06 apr 2016
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Drury Way
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione02676889
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HAVENSTREET LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 mag 1998
    Consegnato il 02 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 10 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole (first) that plot or area of ground lying generally on the north west of woodside road, bridge of don, aberdeen in the parish of old machar & county of aberdeen extending to one acre & two hundred & sixty six decimal or thousandth parts of an acre (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC.
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1989
    Consegnato il 01 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land k/a:- the staton & staveley site lying to the north west of north circular road, neasden london borough of brent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north west of the north circular road, neasden l/b of brent title no. Ngl 472350.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north west of the north circular road, neasden l/b of brent title no mx 306400.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1987
    Consegnato il 02 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining railway, neasden brent, title no:- mx 305400.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Fixed charge
    Creato il 14 feb 1986
    Consegnato il 25 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all moneys now or hereafter deposited by the company as a continuing security until all liabilities of the company to the bank have been full repaid to the bank and/or otherwise wholly satisfied and discharged.
    Persone aventi diritto
    • County Bank Limited.
    Transazioni
    • 25 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Second legal charge
    Creato il 17 ago 1984
    Consegnato il 24 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west side of the north circular road brent london. Title no. Ngl 472350. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (U.K) PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 17 ago 1984
    Consegnato il 24 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate on the north west side of the north circular road neasden title no ngl 472350 and f/h land known as site 28 fourth way wembley trading estate wembley london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • County Bank Limited
    Transazioni
    • 24 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Second legal mortgage
    Creato il 17 ago 1984
    Consegnato il 24 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land forming part of wembley stadium trading estate wembley title no ngl 486497. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (U.K) PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 26 lug 1982
    Consegnato il 06 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (U.K) PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0