PROVIDA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROVIDA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01002622
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROVIDA LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PROVIDA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROVIDA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FUSION EQUIPMENT LIMITED23 set 200823 set 2008
    FUSION EQUIPMENT PLC11 feb 200811 feb 2008
    FUSION GROUP PLC19 gen 199019 gen 1990
    FUSION EQUIPMENT LIMITED17 feb 197117 feb 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROVIDA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per PROVIDA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2016

    Stato del capitale al 21 mar 2016

    • Capitale: GBP 511,120
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed fusion equipment LIMITED\certificate issued on 08/12/15
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 nov 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin James Raine il 01 ago 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mar 2015

    Stato del capitale al 19 mar 2015

    • Capitale: GBP 511,120
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2014

    Stato del capitale al 25 mar 2014

    • Capitale: GBP 511,120
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin James Raine il 17 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Eric Bridgstock il 17 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin James Raine il 21 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Eric Bridgstock il 21 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Neil Anthony Green il 21 ott 2009

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PROVIDA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Neil Anthony
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    Segretario
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    British81192040003
    BRIDGSTOCK, Eric
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    Amministratore
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    EnglandBritish120942230001
    RAINE, Kevin James
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    Amministratore
    Smeckley Wood Close
    Chesterfield Trading Estate
    S41 9PZ Sheepbridge, Chesterfield
    Derbyshire,
    EnglandBritish66851610004
    CAMERON, Kenneth James Coats
    2 Sheards Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    2 Sheards Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5NJ Sheffield
    South Yorkshire
    British59193510002
    GREEN, Neil Anthony
    Apartment 153 City South
    39 City Road East
    M15 4QA Manchester
    Segretario
    Apartment 153 City South
    39 City Road East
    M15 4QA Manchester
    British81192040001
    WILKES, John Michael
    Wellclose Cottage Harper Hill
    Wingerworth
    S42 6QS Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Wellclose Cottage Harper Hill
    Wingerworth
    S42 6QS Chesterfield
    Derbyshire
    British6911490001
    WILKES, Susan Mary
    Moor House North Moor Road
    Walkeringham
    DN10 4LW Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Moor House North Moor Road
    Walkeringham
    DN10 4LW Doncaster
    South Yorkshire
    British142351540001
    BRIDGSTOCK, Eric
    The Homestead
    Edale Road
    S33 6RF Hope
    Derbyshire
    Amministratore
    The Homestead
    Edale Road
    S33 6RF Hope
    Derbyshire
    United KingdomBritish79662230001
    BRIDGSTOCK, Petronilla Monica Mary
    The Homestead
    Edale Road Hope Valley
    S33 6RF Hope
    Derbyshire
    Amministratore
    The Homestead
    Edale Road Hope Valley
    S33 6RF Hope
    Derbyshire
    United KingdomBritish56337300001
    CAMERON, Kenneth James Coats
    2 Sheards Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Sheards Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5NJ Sheffield
    South Yorkshire
    British59193510002
    DUNKEY, Edwin Albert Walter
    121 Longcroft Road
    S18 8XW Dronfield Woodhouse
    Derbyshire
    Amministratore
    121 Longcroft Road
    S18 8XW Dronfield Woodhouse
    Derbyshire
    British75639080001
    JENKINS, Patrick William
    18 Stonelow Crescent
    Dronfield
    S18 6ES Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    18 Stonelow Crescent
    Dronfield
    S18 6ES Sheffield
    South Yorkshire
    British26630670001
    KENWORTHY, David Michael Anthony
    9 Oxclose Drive
    Dronfield Woodhouse
    S18 8XP Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    9 Oxclose Drive
    Dronfield Woodhouse
    S18 8XP Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish62701700001
    LEWOSKI, Edward Joseph
    903 Chesterfield Road
    Woodseats
    S8 0SS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    903 Chesterfield Road
    Woodseats
    S8 0SS Sheffield
    South Yorkshire
    British59298920001
    NAYLOR, Graham James
    Silverdale House
    Rowland
    DE45 1NR Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Silverdale House
    Rowland
    DE45 1NR Bakewell
    Derbyshire
    British6796020001
    NAYLOR, Sandra Elizabeth
    Silverdale House
    Rowland
    DE45 1NR Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Silverdale House
    Rowland
    DE45 1NR Bakewell
    Derbyshire
    British6911510001
    REYNOLDS, David William
    High Street
    Bulkington
    SN10 1SJ Devizes
    Farthings
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    Bulkington
    SN10 1SJ Devizes
    Farthings
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136871710001
    WEAVERS, David Frank
    62 Green Lane
    Dronfield
    S18 6LP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    62 Green Lane
    Dronfield
    S18 6LP Sheffield
    South Yorkshire
    British59193490001
    WILKES, John Michael
    Wellclose Cottage Harper Hill
    Wingerworth
    S42 6QS Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Wellclose Cottage Harper Hill
    Wingerworth
    S42 6QS Chesterfield
    Derbyshire
    British6911490001
    WILKES, Susan Mary
    Moor House North Moor Road
    Walkeringham
    DN10 4LW Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Moor House North Moor Road
    Walkeringham
    DN10 4LW Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish142351540001

    PROVIDA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 23 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a "butt fusion (fusion hire)" building chesterfield trading estate smeckley wood close chesterfield derbyshire t/n dy 258514 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1995
    Consegnato il 10 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a piece of land containing an area of 1.23 acres or thereabouts situate off carrwood road on chesterfiled trading estate sheepbridge derbyshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 mar 1994
    Consegnato il 21 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit BT88/4B south church industrial estate bishop auckland t/n DU136056 durham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 nov 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a all those two pieces of land containing a combined area of 5.57 acres or thereabouts situate to the southern side of carrwood road on the chesterfield trading estate at sheepbridge chesterfield derbyshire part dy 242569 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 nov 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a all those 2 plots of land contained in an area of 2.57 acres or thereabouts situate at smeckleywood close chesterfield trading estate sheepbridge chesterfield derbyshire part t/n dy 242569 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 01 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Office and workshop, woodburn road, blackburn industrial estate, blackburn, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 02 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to an advance payment guarantee dated 27 april 1993IN favour of petroleum gas company for £206,626.00
    Brevi particolari
    The sum of £206,625.00 together with interest accrued now or to be held by national westminster PLC on an account numbered 43382118 and earmarked or designnated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement.
    Creato il 29 lug 1991
    Consegnato il 15 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,390. under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest in the agreements. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited.
    Transazioni
    • 15 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 09 ott 1990
    Consegnato il 18 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15472-50 due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    All its rights, titles and interest in and to all sums payable. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited.
    Transazioni
    • 18 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1990
    Consegnato il 18 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 0.99 acres of land situate at chesterfield trading estate smeckley wood close sheepbridge, chesterfield derbyshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1990
    Consegnato il 18 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the west side of carnwood road sheepbridge, chesterfield derbyshire, title no DY124915 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1990
    Consegnato il 18 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of broombank road sheepbridge, derbyshire title no DY159111 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 mar 1990
    Consegnato il 07 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1986
    Consegnato il 23 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the other companies named thereon to the chargee on any account whatsover
    Brevi particolari
    2.2 acres of land & buildings at calley white lane industrial estate dronfield sheffield including all fixtures & fittings (other than trade fixtures) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Standard security presented at sasines on the 18/4/85
    Creato il 18 apr 1985
    Consegnato il 26 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 9/4/85
    Brevi particolari
    Lease of ground and buildings known as units 7 & 8 brewster square brucefield industrial estate livingstone, west lothian.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 07 ago 1984
    Consegnato il 11 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or fusion plastics LTD. Butt fusion services LTD. J g e limited and or allam generators to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1984
    Consegnato il 19 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or fusion plastics limited and/or butt fusion services limited and/or allam generators limited and/or J.C.E. limited to yorkshire bank PLC on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Legal mortgage 2.2 acres of land & buildings at calley white lane industrial est, dronfield, sheffield.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC.
    Transazioni
    • 19 giu 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0