AUK REALISATIONS LIMITED

AUK REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAUK REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01004276
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di AUK REALISATIONS LIMITED?

    • fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali e relative macchine (30300) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova AUK REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11th Floor Landmark St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AUK REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AIM ALTITUDE UK LIMITED08 set 201708 set 2017
    AIM AVIATION (JECCO) LIMITED15 dic 198915 dic 1989
    JECCO AVIATION LIMITED24 feb 198224 feb 1982
    C.GROUP LIMITED(THE)09 mar 197109 mar 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di AUK REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per AUK REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al12 dic 2022
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma26 dic 2022
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al12 dic 2021
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per AUK REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 giu 2024

    33 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    pagineAM22

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    36 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    63 pagineAM10

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Change name to auk realisations LIMITED 27/07/2022
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed aim altitude uk LIMITED\certificate issued on 30/08/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name30 ago 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 lug 2022

    RES15

    Risultato della riunione dei creditori

    6 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    86 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Viscount Road, Aviation Business Park Bournemouth International Airport, Hurn Christchurch BH23 6BU England a 11th Floor Landmark St Peters Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB in data 27 giu 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Neil Taggart come amministratore in data 17 feb 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Wayne Ball come amministratore in data 09 feb 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Qinghong Liu come amministratore in data 01 mag 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Jing Guo come amministratore in data 01 mag 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Li Fan come amministratore in data 01 mag 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Mark Bower come amministratore in data 30 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Colin Philip Thornton come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    29 pagineAA

    Notifica di Aim Altitude Limited come persona con controllo significativo il 19 apr 2019

    2 paginePSC02

    Chi sono gli amministratori di AUK REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FAN, Li
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Amministratore
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    United KingdomChineseCompany Director269686080001
    GUO, Jing
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Amministratore
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    ChinaChineseCompany Director268310700001
    LIU, Qinghong
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Amministratore
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    EnglandChineseCompany Director269686440001
    STODDART, Mark
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Amministratore
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    EnglandBritishFinance Director220064290001
    TAGGART, Neil
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Amministratore
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Northern IrelandBritishCompany Director279892730001
    EDWARDS, Mark
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    153178340001
    FENN, Nicholas Patrick
    37 School Road
    West Wellow
    SO51 6AR Romsey
    Hampshire
    Segretario
    37 School Road
    West Wellow
    SO51 6AR Romsey
    Hampshire
    British10281800001
    GREEN, Robert Anthony
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    BritishFinance Director10281810001
    GREEN, Robert Anthony
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    British10281810001
    WINSHIP, Simon Mark
    126 River Way
    BH23 2QU Christchurch
    Segretario
    126 River Way
    BH23 2QU Christchurch
    British63193290003
    BALL, Wayne
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Amministratore
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    EnglandBritishOperations Director185821680001
    BOWER, Richard Mark
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Amministratore
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    EnglandBritishDirector185795210001
    EDWARDS, Mark John
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Amministratore
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    United KingdomBritishDirector56562210001
    FORBES, Peter Patrick Spencer
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director16260380002
    HEATH, Robert John
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishEngineer74802290002
    LEITCH, Andrew Jack
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Amministratore
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    United KingdomBritishFinance Director154333950001
    LEVY, Max
    12 Landers Reach
    Lychett Matravers
    BH16 6NB Poole
    Dorset
    Amministratore
    12 Landers Reach
    Lychett Matravers
    BH16 6NB Poole
    Dorset
    EnglandBritishOperations Director110629560001
    LOCK, David
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishFinancial Controller185795330001
    MACDONALD-HALL, Caspar
    School Farm
    Lockerley
    SO51 0JH Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    School Farm
    Lockerley
    SO51 0JH Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director10281830001
    MANN, Michael Alan
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Amministratore
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller188031590001
    MCDONALD, Shaun Owen
    152 Stony Lane
    Burton
    BH23 7LD Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    152 Stony Lane
    Burton
    BH23 7LD Christchurch
    Dorset
    BritishCompany Director30598230001
    READE, Bryan
    27 Moneyfly Road
    BH31 6BL Verwood
    Dorset
    Amministratore
    27 Moneyfly Road
    BH31 6BL Verwood
    Dorset
    BritishCompany Director30598250001
    ROBERTS, Anthony
    8 Robert Louis Stevenson Avenue
    Westbourne
    Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    8 Robert Louis Stevenson Avenue
    Westbourne
    Bournemouth
    Dorset
    BritishCompany Director41765280001
    SMITH, Jeffrey Colin
    Merdon Manor
    Hursley
    SO21 2JJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Merdon Manor
    Hursley
    SO21 2JJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director10281820001
    TAPPENDEN, Michael John
    49 Oakhurst Road
    West Moors
    BH22 0DP Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    49 Oakhurst Road
    West Moors
    BH22 0DP Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishDirector64363900001
    THORNTON, Colin Philip
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Amministratore
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    EnglandBritishAircraft Interiors89175510001
    WARD, David
    27 Bartons Road
    SP6 1JD Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    27 Bartons Road
    SP6 1JD Fordingbridge
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director30598240002

    Chi sono le persone con controllo significativo di AUK REALISATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aim Altitude Limited
    Aviation Business Park
    Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1 Viscount Road
    England
    19 apr 2019
    Aviation Business Park
    Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1 Viscount Road
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House (England & Wales)
    Numero di registrazione9804626
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Aim Altitude Limited
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    30 nov 2016
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione9804626
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Jecco House
    England
    06 apr 2016
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Jecco House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione7275471
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    AUK REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 nov 2016
    Consegnato il 25 nov 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 mag 2016
    Consegnato il 10 mag 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 ott 2013
    Consegnato il 09 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    19 and 21 boscombe road, bournemouth t/no DT139474; land and buildings on the south side of boscombe grove road, bournemouth t/no DT94622; 188, 190, 194 spring road, bournemouth t/no DT134760.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 ott 2013
    Consegnato il 08 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 dic 2012
    Consegnato il 21 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 30 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    19 and 21 boscombe grove road, bournemouth t/no DT139474. Land and buildings on the south side of boscombe grove road, bournemouth t/no DT94622 and 188, 190, 192 and 194 spring road, bournemouth t/no DT134760 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 30 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 30 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 30 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    188 190 192 and 194 spring road bournemouth t/n DT134760 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north side of boscombe grove road bournemouth t/n DT94622 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19 & 21 boscombe grove road bournemouth t/n DT139474 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 ott 2004
    Consegnato il 15 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    £3,187.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit account in the sum of £3,187.50 as per the terms of the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Bournemouth International Airport Limited
    Transazioni
    • 15 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 apr 1983
    Consegnato il 18 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof including fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, go odwill and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    AUK REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 giu 2022Inizio dell'amministrazione
    19 giu 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Helen Dale
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Jonathan Roden
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Andrew Charters
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    2
    DataTipo
    19 giu 2023Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Helen Dale
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Jonathan Roden
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Praticante
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Andrew Charters
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0