LIBRA NURSING HOMES LIMITED
Panoramica
Nome della società | LIBRA NURSING HOMES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01004767 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Fifth Floor 80 Hammersmith Road W14 8UD London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
NESTOR NURSING HOMES LIMITED | 15 mar 1971 | 15 mar 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Moran come amministratore in data 01 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Mark Moran come amministratore in data 01 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason David Lock come amministratore in data 01 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 21 Exhibition House Addison Bridge Place London W14 8XP England* in data 23 lug 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Priory House, Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TP* in data 04 ago 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David James Hall il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL, David James | Segretario | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | British | Company Lawyer | 132246660001 | |||||
HALL, David James | Amministratore | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | Company Lawyer | 132246660001 | ||||
GREENSMITH, Paul John | Segretario | 8 Ennerdale Road Kew TW9 3PG Richmond Upon Thames Surrey | British | Director | 150227000001 | |||||
HATHER, Jon | Segretario | 83 High Street BR6 7BB Farnborough Village Kent | British | 68848420001 | ||||||
MUKERJI, Swagatam | Segretario | The Peacocks Drews Park, Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | British | Finance Director | 121222440001 | |||||
O'CONNELL, Kevin Daniel | Segretario | 27 Stag Green Avenue AL9 5EB Hatfield Hertfordshire | English | Company Secretary | 15336730002 | |||||
PAYNE, Keith | Segretario | 90 Long Plough Aston Clinton HP22 5HD Aylesbury Buckinghamshire | British | 65484490001 | ||||||
PAYNE, Keith | Segretario | 90 Long Plough Aston Clinton HP22 5HD Aylesbury Buckinghamshire | British | 65484490001 | ||||||
PURSE, Stephen John | Segretario | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | British | 58759290001 | ||||||
SPRUZEN, David Andrew | Segretario | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | British | Director | 110080200001 | |||||
VAUGHAN, Richard David Crofts | Segretario | 58 Peterborough Road SW6 3EB London | British | Director | 2662790001 | |||||
WEIGHT, James Dominic | Segretario | 11 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | British | Chief Financial Officer | 73750450005 | |||||
WOOD, John | Segretario | Pear Tree Cottage Bishopstone HP12 8SH Aylesbury Buckinghamshire | British | 59323380001 | ||||||
BEAUMONT, Susan Karen | Amministratore | Jerico Farm House Yarnton Road OX8 1EB Cassington Oxfordshire | British | Company Director | 11755300002 | |||||
BRADSHAW, Stephen Wallace | Amministratore | Great Elm BA11 3NY Nr Frome Glenthorpe Somerset | England | British | Director | 132026810001 | ||||
CHAPMAN, Clive Richard | Amministratore | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | Finance Director | 86129050001 | ||||
EASTERMAN, Philip Harry | Amministratore | 3 Oakview Hyde Heath HP6 5SE Amersham Buckinghamshire | British | Director | 63476990001 | |||||
GREENSMITH, Paul John | Amministratore | 8 Ennerdale Road Kew TW9 3PG Richmond Upon Thames Surrey | England | British | Director | 150227000001 | ||||
HEYWOOD, Anthony George | Amministratore | Yamas House Chiddingly Road TN21 0LJ Horam East Sussex | British | Director | 30119220003 | |||||
LOCK, Jason David | Amministratore | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | Finance Director | 144822040001 | ||||
MORAN, Mark | Amministratore | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor | United Kingdom | British | Director | 60066000008 | ||||
PATEL, Chaitanya Bhupendra | Amministratore | Robin Hill Warren Lane KT22 0ST Oxshott Surrey | United Kingdom | British | Director | 63915280004 | ||||
PAYNE, Keith | Amministratore | 90 Long Plough Aston Clinton HP22 5HD Aylesbury Buckinghamshire | British | Director | 65484490001 | |||||
PRIESTLEY, Jennifer | Amministratore | 48 Coniger Road SW6 3TA London | United Kingdom | British | Managing Director | 10742250001 | ||||
PURSE, Stephen John | Amministratore | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | England | British | Finance Director | 58759290001 | ||||
ROGERS, Michael Greig | Amministratore | 1 Jenningsbury Court London Road SG13 7NS Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 107156650001 | ||||
SCOTT, Kenneth Cameron Knowles | Amministratore | Weeke Hill TQ6 0JT Dartmouth Little Weeke Devon | United Kingdom | British | Legal Counsel | 86218520002 | ||||
SPRUZEN, David Andrew | Amministratore | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | England | British | Director | 110080200001 | ||||
STEWART, Serena Jane | Amministratore | 23 Lindsey Street CM16 6RB Epping Essex | British | Director | 57758710001 | |||||
THOMPSON, Christopher, Professor | Amministratore | 3 Preshaw House Preshaw SO32 1HP Upham Hampshire | United Kingdom | British | Doctor | 162000490001 | ||||
TORBETT, David | Amministratore | 17 Moultway Crescent GU15 1PW Camberley Surrey | British | Operations Director | 14151780003 | |||||
VAUGHAN, Richard David Crofts | Amministratore | 58 Peterborough Road SW6 3EB London | England | British | Director | 2662790001 | ||||
WEIGHT, James Dominic | Amministratore | 11 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | England | British | Chief Financial Officer | 73750450005 | ||||
WILSON, Andrew Stephen | Amministratore | 5 Court Lane Gardens Dulwich SE21 7DZ London | United Kingdom | British | Develop & Aquisition Director | 82667700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libra Health Ltd | 06 apr 2016 | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LIBRA NURSING HOMES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creato il 09 nov 2005 Consegnato il 22 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 15 set 2005 Consegnato il 26 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H property k/a priory hospital altrincham rappax road altrincham cheshire t/no GM32147, priory hospital bristol heath house lane off bell hill bristol t/no AV204454, f/h property k/a priory grange heath house lane purdown bristol t/no AV247767. For details of further properties charge please refer to form 395. all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery and floating charge all assets no effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Amendment and restatement deed | Creato il 19 set 2003 Consegnato il 09 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the other obligors or the issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All shares held in the future and in relation to such shares; all dividends, interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Borrower debenture | Creato il 04 set 2003 Consegnato il 23 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The aggregate of all obligations moneys and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all right title and interest in and to the english real property, the tangible moveable property, the obligor accounts; the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security accession deed (the "security accession deed") made by the acceding charging company in favour of the royal bank of scotland PLC as trustee for the secured parties (the "trustee") in relation to a debenture (the "debenture") dated 10 june 2002 made by priory healthcare acquisition co. Limited in favour of the trustee | Creato il 10 giu 2002 Consegnato il 17 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All financial obligations at any time due, owing or incurred by priory healthcare acquisition co. Limited or any borrower or any guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The real property; the freehold property known as unsted park hospital, munstead heath, godalming t/no: sy 412405, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property and goodwill, the investments, the shares, all dividends, by way of first floating charge the whole of the acceding charging company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture as amended by a supplemental deed dated 10 february 2000 | Creato il 31 gen 2000 Consegnato il 17 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 giu 1994 Consegnato il 25 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from breamco 116 limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Brevi particolari All that f/h property k/a thames bank nursing homes goring-on-thames oxfordshire with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 giu 1994 Consegnato il 25 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from breamco 116 limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Brevi particolari All that f/h land and buildings k/a unstead park hospital munstead heath godalming surrey t/n SY412405 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 giu 1994 Consegnato il 21 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 26 mar 1993 Consegnato il 01 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or nestor medical services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Thames bank nursing home goring on thames oxfordshire and the proceeds ofsale thereof by way of assignment the goodwill of the business together with the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Third party charge | Creato il 29 dic 1989 Consegnato il 15 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from nestor-bna PLC to the chargee under the terms of a facility agreement dated 29/12/89 | |
Brevi particolari United park in the districts of waverley and guildford in the parishes of godalming, burbridge, bramley and shalford title no sy 412405 the plant, machinery and fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 29 giu 1989 Consegnato il 14 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from nestor-bna PLC. To the chargee under the terms of a lease and/or an option agreement both dated 29.6.89 and this charge. | |
Brevi particolari Thames bank nursing home, goring-on-thames, oxfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Collateral debenture | Creato il 30 apr 1986 Consegnato il 09 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from nestor-bna limited to the chargee. | |
Brevi particolari (See doc M46 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Collateral debenture | Creato il 30 apr 1986 Consegnato il 09 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from nestor-bna limited to the chargee. | |
Brevi particolari (See doc M45 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 apr 1986 Consegnato il 09 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari F/H land and premises known as unstead park, godalming, surrey tn: sy 412405 and the proceeds of sale thereof (see doc M44 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0