LIBRA NURSING HOMES LIMITED

LIBRA NURSING HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLIBRA NURSING HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01004767
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fifth Floor
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NESTOR NURSING HOMES LIMITED15 mar 197115 mar 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2016

    Stato del capitale al 14 lug 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Mark Moran come amministratore in data 01 mar 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2015

    Stato del capitale al 25 giu 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Mark Moran come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jason David Lock come amministratore in data 01 apr 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2014

    Stato del capitale al 25 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 21 Exhibition House Addison Bridge Place London W14 8XP England* in data 23 lug 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Priory House, Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TP* in data 04 ago 2011

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David James Hall il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALL, David James
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Segretario
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    BritishCompany Lawyer132246660001
    HALL, David James
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Amministratore
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    EnglandBritishCompany Lawyer132246660001
    GREENSMITH, Paul John
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector150227000001
    HATHER, Jon
    83 High Street
    BR6 7BB Farnborough Village
    Kent
    Segretario
    83 High Street
    BR6 7BB Farnborough Village
    Kent
    British68848420001
    MUKERJI, Swagatam
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director121222440001
    O'CONNELL, Kevin Daniel
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    EnglishCompany Secretary15336730002
    PAYNE, Keith
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British65484490001
    PAYNE, Keith
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British65484490001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Segretario
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    British58759290001
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Segretario
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    BritishDirector110080200001
    VAUGHAN, Richard David Crofts
    58 Peterborough Road
    SW6 3EB London
    Segretario
    58 Peterborough Road
    SW6 3EB London
    BritishDirector2662790001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Segretario
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    BritishChief Financial Officer73750450005
    WOOD, John
    Pear Tree Cottage
    Bishopstone
    HP12 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    Pear Tree Cottage
    Bishopstone
    HP12 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    British59323380001
    BEAUMONT, Susan Karen
    Jerico Farm House
    Yarnton Road
    OX8 1EB Cassington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Jerico Farm House
    Yarnton Road
    OX8 1EB Cassington
    Oxfordshire
    BritishCompany Director11755300002
    BRADSHAW, Stephen Wallace
    Great Elm
    BA11 3NY Nr Frome
    Glenthorpe
    Somerset
    Amministratore
    Great Elm
    BA11 3NY Nr Frome
    Glenthorpe
    Somerset
    EnglandBritishDirector132026810001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Amministratore
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishFinance Director86129050001
    EASTERMAN, Philip Harry
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector63476990001
    GREENSMITH, Paul John
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishDirector150227000001
    HEYWOOD, Anthony George
    Yamas House
    Chiddingly Road
    TN21 0LJ Horam
    East Sussex
    Amministratore
    Yamas House
    Chiddingly Road
    TN21 0LJ Horam
    East Sussex
    BritishDirector30119220003
    LOCK, Jason David
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Amministratore
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    EnglandBritishFinance Director144822040001
    MORAN, Mark
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    Amministratore
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    United KingdomBritishDirector60066000008
    PATEL, Chaitanya Bhupendra
    Robin Hill
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Robin Hill
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishDirector63915280004
    PAYNE, Keith
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    90 Long Plough
    Aston Clinton
    HP22 5HD Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishDirector65484490001
    PRIESTLEY, Jennifer
    48 Coniger Road
    SW6 3TA London
    Amministratore
    48 Coniger Road
    SW6 3TA London
    United KingdomBritishManaging Director10742250001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Amministratore
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    EnglandBritishFinance Director58759290001
    ROGERS, Michael Greig
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive107156650001
    SCOTT, Kenneth Cameron Knowles
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    Amministratore
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    United KingdomBritishLegal Counsel86218520002
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Amministratore
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    EnglandBritishDirector110080200001
    STEWART, Serena Jane
    23 Lindsey Street
    CM16 6RB Epping
    Essex
    Amministratore
    23 Lindsey Street
    CM16 6RB Epping
    Essex
    BritishDirector57758710001
    THOMPSON, Christopher, Professor
    3 Preshaw House
    Preshaw
    SO32 1HP Upham
    Hampshire
    Amministratore
    3 Preshaw House
    Preshaw
    SO32 1HP Upham
    Hampshire
    United KingdomBritishDoctor162000490001
    TORBETT, David
    17 Moultway Crescent
    GU15 1PW Camberley
    Surrey
    Amministratore
    17 Moultway Crescent
    GU15 1PW Camberley
    Surrey
    BritishOperations Director14151780003
    VAUGHAN, Richard David Crofts
    58 Peterborough Road
    SW6 3EB London
    Amministratore
    58 Peterborough Road
    SW6 3EB London
    EnglandBritishDirector2662790001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChief Financial Officer73750450005
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Amministratore
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritishDevelop & Aquisition Director82667700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LIBRA NURSING HOMES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Libra Health Ltd
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    06 apr 2016
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione1355923
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LIBRA NURSING HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 22 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (Facility Agent)
    Transazioni
    • 22 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 15 set 2005
    Consegnato il 26 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a priory hospital altrincham rappax road altrincham cheshire t/no GM32147, priory hospital bristol heath house lane off bell hill bristol t/no AV204454, f/h property k/a priory grange heath house lane purdown bristol t/no AV247767. For details of further properties charge please refer to form 395. all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery and floating charge all assets no effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 26 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amendment and restatement deed
    Creato il 19 set 2003
    Consegnato il 09 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the other obligors or the issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares held in the future and in relation to such shares; all dividends, interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Priory Securitisation Holdings Limited (The "Trustee")
    Transazioni
    • 09 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Borrower debenture
    Creato il 04 set 2003
    Consegnato il 23 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The aggregate of all obligations moneys and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the english real property, the tangible moveable property, the obligor accounts; the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security accession deed (the "security accession deed") made by the acceding charging company in favour of the royal bank of scotland PLC as trustee for the secured parties (the "trustee") in relation to a debenture (the "debenture") dated 10 june 2002 made by priory healthcare acquisition co. Limited in favour of the trustee
    Creato il 10 giu 2002
    Consegnato il 17 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All financial obligations at any time due, owing or incurred by priory healthcare acquisition co. Limited or any borrower or any guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property; the freehold property known as unsted park hospital, munstead heath, godalming t/no: sy 412405, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property and goodwill, the investments, the shares, all dividends, by way of first floating charge the whole of the acceding charging company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Trustee, Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Trustee or as an Additional Trustee
    Transazioni
    • 17 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture as amended by a supplemental deed dated 10 february 2000
    Creato il 31 gen 2000
    Consegnato il 17 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1994
    Consegnato il 25 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from breamco 116 limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a thames bank nursing homes goring-on-thames oxfordshire with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1994
    Consegnato il 25 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from breamco 116 limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a unstead park hospital munstead heath godalming surrey t/n SY412405 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 giu 1994
    Consegnato il 21 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 01 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or nestor medical services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Thames bank nursing home goring on thames oxfordshire and the proceeds ofsale thereof by way of assignment the goodwill of the business together with the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party charge
    Creato il 29 dic 1989
    Consegnato il 15 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from nestor-bna PLC to the chargee under the terms of a facility agreement dated 29/12/89
    Brevi particolari
    United park in the districts of waverley and guildford in the parishes of godalming, burbridge, bramley and shalford title no sy 412405 the plant, machinery and fixtures.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 29 giu 1989
    Consegnato il 14 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from nestor-bna PLC. To the chargee under the terms of a lease and/or an option agreement both dated 29.6.89 and this charge.
    Brevi particolari
    Thames bank nursing home, goring-on-thames, oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Leasing (June) Limited.
    Transazioni
    • 14 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 30 apr 1986
    Consegnato il 09 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from nestor-bna limited to the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M46 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Collateral debenture
    Creato il 30 apr 1986
    Consegnato il 09 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from nestor-bna limited to the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M45 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 09 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 30 apr 1986
    Consegnato il 09 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land and premises known as unstead park, godalming, surrey tn: sy 412405 and the proceeds of sale thereof (see doc M44 for further details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0