HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEATH INSURANCE BROKING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01005219
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    C E HEATH (INSURANCE BROKING) LIMITED25 apr 198825 apr 1988
    C.E. HEATH & CO. (INSURANCE BROKING) LIMITED18 mar 197118 mar 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Alistair Charles Peel come segretario in data 09 ago 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Lindsay Mcgowan come segretario in data 09 ago 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2016

    Stato del capitale al 02 feb 2016

    • Capitale: GBP 55
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew Pike come amministratore in data 09 feb 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Christopher Ross come amministratore in data 09 feb 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2015

    Stato del capitale al 05 feb 2015

    • Capitale: GBP 55
    SH01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Mugge come amministratore in data 26 gen 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2014

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 55
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 9 Alie Street London E1 8DE* in data 19 ago 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr William Lindsay Mcgowan come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hl Corporate Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Christopher Ross il 11 ott 2012

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEEL, Alistair Charles
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Segretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    249410010001
    PIKE, Matthew William
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Amministratore
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritish187274510001
    MCGOWAN, William Lindsay
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Segretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    180337270001
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Segretario
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    Segretario
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    Segretario
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1054707
    43700080007
    BARTON, Michael Keith
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    Amministratore
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    EnglandUnited States109126210001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Amministratore
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritish72374560002
    BROADHURST, Timothy Edward
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish8657480001
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish61928170002
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Amministratore
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    Amministratore
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritish4555310002
    DEXTER, Neil Edward
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish42053970001
    ELDRET, Kenneth George
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    British34990880001
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritish77656210001
    HARRISON, Robert Melville
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    British8722560001
    HORNER, Frank Henry Leslie
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    British28353000001
    HUGHES, Michael Harold
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    Amministratore
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    British65226980002
    HUGHES, Paul John
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish5389800001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    Amministratore
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritish147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Danish8719670001
    LETBY, Roger David
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    Amministratore
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    British28585270003
    MACKAY, Ian Hamish Noel
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    Amministratore
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    British104334150001
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    Amministratore
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    British34988570004
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    British34988570001
    MCCARTHY, Paul Frank
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    Amministratore
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    British65173730001
    MONEY, Anthony John
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritish8785440001
    MUGGE, Mark Stephen
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Amministratore
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    EnglandAmerican162920630001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    British66912140001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    British66912140001
    NICHOLS, David William
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    British6384890001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Amministratore
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    PROCTOR, Jonathan Paul
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    Amministratore
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    British8638320001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Friary Intermediate Limited
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    06 apr 2016
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione4404202
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 feb 2000
    Consegnato il 09 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 1 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation"),
    Creato il 23 set 1999
    Consegnato il 01 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a charge
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's
    Transazioni
    • 01 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third guarantee and debenture
    Creato il 31 dic 1997
    Consegnato il 14 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 03 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 01 nov 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed dated 01/09/89
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 07 nov 1991
    Consegnato il 12 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deposit agreement
    Brevi particolari
    The balances for the time being standing to the credit of any accounts with the bank see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 12 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 01 set 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See schedule attached to form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's as Trustee
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit charge
    Creato il 08 nov 1988
    Consegnato il 23 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title & interest of the company in & all sums from time to time standing to the credit of each l/c deposit account in the name of the company opened with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge document
    Creato il 16 apr 1986
    Consegnato il 25 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A) all sums of money which may now or hereafter be held by or for the account of the bank in the name or the company at the main office of the bank in london together with all interest accruing from time to time thereon. B) all shares stocks, bonds debentures certificates of deposit or other securities (see doc M21 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    Transazioni
    • 25 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 21 feb 1983
    Consegnato il 23 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account and monies and investments standing to the credit in other iba accounts of the company. (See doc M.20).
    Persone aventi diritto
    • The Corporation of Lloyd's
    Transazioni
    • 23 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0