HOMES EXCHANGE LIMITED

HOMES EXCHANGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOMES EXCHANGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01006679
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOMES EXCHANGE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HOMES EXCHANGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Integration House
    Rye Close Ancells Business Park
    GU51 2QG Fleet
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOMES EXCHANGE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLROY HOMES LIMITED20 lug 198920 lug 1989
    KEWGATE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED01 apr 197101 apr 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOMES EXCHANGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HOMES EXCHANGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2012

    Stato del capitale al 08 mag 2012

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    10 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Alan Christopher Martin il 27 giu 2011

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Christopher Martin il 27 giu 2011

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagineMG02

    Cessazione della carica di Joy Baldry come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Alan Christopher Martin come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 feb 2011

    • Capitale: GBP 10
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Nicholas Holt come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    9 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di HOMES EXCHANGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Alan Christopher
    Harvest Crescent
    Ancells Business Park
    GU51 2UZ Fleet
    Sentinel House
    Hampshire
    England
    Segretario
    Harvest Crescent
    Ancells Business Park
    GU51 2UZ Fleet
    Sentinel House
    Hampshire
    England
    British161311370001
    MARTIN, Alan Christopher
    Harvest Crescent
    Ancells Business Park
    GU51 2UZ Fleet
    Sentinel House
    Hampshire
    Amministratore
    Harvest Crescent
    Ancells Business Park
    GU51 2UZ Fleet
    Sentinel House
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant89694100002
    ASHMORE, Justine Inez
    62a North Walls
    SO23 8DP Winchester
    Hampshire
    Segretario
    62a North Walls
    SO23 8DP Winchester
    Hampshire
    British105482530003
    BALDRY, Joy Elizabeth
    Talisman Close
    RG45 6JE Crowthorne
    Bedrock
    Berkshire
    Segretario
    Talisman Close
    RG45 6JE Crowthorne
    Bedrock
    Berkshire
    British128661410001
    GREEN, David Martyn Jackson
    Little Kingshill
    HP16 0EL Great Missenden
    4 Longfield
    Bucks
    Segretario
    Little Kingshill
    HP16 0EL Great Missenden
    4 Longfield
    Bucks
    British139794240001
    LAWRIE, Edwin John
    25 Downside Road
    SM2 5HR Sutton
    Surrey
    Segretario
    25 Downside Road
    SM2 5HR Sutton
    Surrey
    British21957820002
    MCLELLAN, Colin Warnock
    50 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middlesex
    Segretario
    50 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant20961750001
    SEYMOUR, Stuart Leslie
    44 Reigate Road
    East Ewell
    KT17 1PX Epsom
    Surrey
    Segretario
    44 Reigate Road
    East Ewell
    KT17 1PX Epsom
    Surrey
    BritishProperty Manager46760780001
    BRUCE, Winston Stanley
    2 Up Fallow
    Lychpit
    RG24 8YW Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    2 Up Fallow
    Lychpit
    RG24 8YW Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director18278470001
    DUNLOP, Roger Napier
    Setherum House
    Benham Park Marsh Benham
    RG20 8LX Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Setherum House
    Benham Park Marsh Benham
    RG20 8LX Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor68979710001
    EYRE, David Alan
    Walnut Cottage
    East Lane
    KT24 6HQ West Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Walnut Cottage
    East Lane
    KT24 6HQ West Horsley
    Surrey
    BritishCompany Director20983450001
    GLEESON, Dermot James
    Hook Farm White Hart Lane
    Wood Street Village
    GU3 3EA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Hook Farm White Hart Lane
    Wood Street Village
    GU3 3EA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director20983460001
    GREEN, David Martyn Jackson
    Little Kingshill
    HP16 0EL Great Missenden
    4 Longfield
    Bucks
    Amministratore
    Little Kingshill
    HP16 0EL Great Missenden
    4 Longfield
    Bucks
    EnglandBritishCompany Director139794240001
    HOGGETT, William Henry
    2 Juniper Close
    Silsoe
    MK45 4EG Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 Juniper Close
    Silsoe
    MK45 4EG Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director9860530001
    HOLT, Nicholas Christopher
    1 Dynevor Road
    TW10 6PF Richmond Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    1 Dynevor Road
    TW10 6PF Richmond Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishDirector10758310003
    JOYCE, Ian Robert
    Meadow Bank
    Downham Road Chatburn
    BB7 4AU Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Meadow Bank
    Downham Road Chatburn
    BB7 4AU Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director104330770001
    KEMP, Mark Andrew
    6 Ibworth Lane
    GU51 1AU Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    6 Ibworth Lane
    GU51 1AU Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant90131740004
    LAWRIE, Edwin John
    25 Downside Road
    SM2 5HR Sutton
    Surrey
    Amministratore
    25 Downside Road
    SM2 5HR Sutton
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary21957820002
    MASSINGHAM, Terence William
    The Triangle
    Winchester Road
    SO32 2AJ Durley
    Hampshire
    Amministratore
    The Triangle
    Winchester Road
    SO32 2AJ Durley
    Hampshire
    BritishDirector122371100001
    MCLELLAN, Colin Warnock
    50 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    50 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middlesex
    BritishDirector20961750001
    ROBINSON, Derek Alan
    35 Upper George Street
    Higham Ferrers
    NN10 8JN Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    35 Upper George Street
    Higham Ferrers
    NN10 8JN Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishBuilding Manager28246610001
    WALLWORK, Paul Anthony Hewitt
    Spring Barn Main Street
    Yarwell
    PE8 6PR Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Spring Barn Main Street
    Yarwell
    PE8 6PR Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director113014520002
    WARREN, John
    116 Winton Drive
    Croxley Green
    WD3 3QT Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    116 Winton Drive
    Croxley Green
    WD3 3QT Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishQuantity Surveyor28246620001
    WILDING, Clive Michael
    16 Mill Drove
    TN22 5AB Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    16 Mill Drove
    TN22 5AB Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector32960240002

    HOMES EXCHANGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating security document
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Agent) as Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1987
    Consegnato il 21 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from colroy properties limited to henry ansbacher & co limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at biggin lane estate, bury road, ramsey, cambridgeshire. T.N. cb 66805 cb 63796.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 21 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental legal charge
    Creato il 23 mag 1986
    Consegnato il 27 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge d/d 24/4/86
    Brevi particolari
    Land at the rear of b paks canning factory at bury road ramsey huntingdon cambridgeshire.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 nov 1985
    Consegnato il 25 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land part of the pine trees village estate at irthlingborough northamptonshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Algemene Bank Nederland Nv.
    Transazioni
    • 25 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 set 1985
    Consegnato il 11 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece or parcel of land situate in gaul road march cambridgeshire and containing six acres and fifteen poles.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 set 1985
    Consegnato il 02 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 50000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H property being land at the rear of B. paks canning factory bury road ramsey huntingdon cambridgeshire.
    Persone aventi diritto
    • Whitworths Developments Limited
    Transazioni
    • 02 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 15 mag 1985
    Consegnato il 20 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 25/4/85
    Brevi particolari
    F/H - land at ramsey in the district of huntingdon containing 4 1/4 acres or thereabouts. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co LTD
    Transazioni
    • 20 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 16 apr 1985
    Consegnato il 23 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the legal charge dated 25/04/84.
    Brevi particolari
    F/H land at ramsey in the district of huntingdon. (For full details see doc no M65).
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 23 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1984
    Consegnato il 27 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land comprising approximately 12 1/2 acres off biggin lane, ramsey, huntingdon, cambridge.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 27 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 14 dic 1983
    Consegnato il 15 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings k/a land at bowbrook road leyland. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Algemene Bank Nederland Nv
    Transazioni
    • 15 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 mag 1981
    Consegnato il 02 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H cleveleys hydro, chatteris place, cleveleys, blackpool.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 14 lug 1980
    Consegnato il 15 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or colroy homes LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H land at lavendon milton keynes bucks B.M. 62650 forming part of bm 42718.
    Persone aventi diritto
    • Schlesinger LTD
    Transazioni
    • 15 lug 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0