HOMES EXCHANGE LIMITED
Panoramica
Nome della società | HOMES EXCHANGE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01006679 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HOMES EXCHANGE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HOMES EXCHANGE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Integration House Rye Close Ancells Business Park GU51 2QG Fleet Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HOMES EXCHANGE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
COLROY HOMES LIMITED | 20 lug 1989 | 20 lug 1989 |
KEWGATE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 01 apr 1971 | 01 apr 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HOMES EXCHANGE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per HOMES EXCHANGE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di beni vacanti | 1 pagine | BONA | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2011 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alan Christopher Martin il 27 giu 2011 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Christopher Martin il 27 giu 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joy Baldry come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Alan Christopher Martin come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2010 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 feb 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Holt come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009 | 9 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2008 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HOMES EXCHANGE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Alan Christopher | Segretario | Harvest Crescent Ancells Business Park GU51 2UZ Fleet Sentinel House Hampshire England | British | 161311370001 | ||||||
MARTIN, Alan Christopher | Amministratore | Harvest Crescent Ancells Business Park GU51 2UZ Fleet Sentinel House Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 89694100002 | ||||
ASHMORE, Justine Inez | Segretario | 62a North Walls SO23 8DP Winchester Hampshire | British | 105482530003 | ||||||
BALDRY, Joy Elizabeth | Segretario | Talisman Close RG45 6JE Crowthorne Bedrock Berkshire | British | 128661410001 | ||||||
GREEN, David Martyn Jackson | Segretario | Little Kingshill HP16 0EL Great Missenden 4 Longfield Bucks | British | 139794240001 | ||||||
LAWRIE, Edwin John | Segretario | 25 Downside Road SM2 5HR Sutton Surrey | British | 21957820002 | ||||||
MCLELLAN, Colin Warnock | Segretario | 50 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middlesex | British | Chartered Accountant | 20961750001 | |||||
SEYMOUR, Stuart Leslie | Segretario | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | Property Manager | 46760780001 | |||||
BRUCE, Winston Stanley | Amministratore | 2 Up Fallow Lychpit RG24 8YW Basingstoke Hampshire | British | Company Director | 18278470001 | |||||
DUNLOP, Roger Napier | Amministratore | Setherum House Benham Park Marsh Benham RG20 8LX Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 68979710001 | ||||
EYRE, David Alan | Amministratore | Walnut Cottage East Lane KT24 6HQ West Horsley Surrey | British | Company Director | 20983450001 | |||||
GLEESON, Dermot James | Amministratore | Hook Farm White Hart Lane Wood Street Village GU3 3EA Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 20983460001 | ||||
GREEN, David Martyn Jackson | Amministratore | Little Kingshill HP16 0EL Great Missenden 4 Longfield Bucks | England | British | Company Director | 139794240001 | ||||
HOGGETT, William Henry | Amministratore | 2 Juniper Close Silsoe MK45 4EG Bedford Bedfordshire | British | Company Director | 9860530001 | |||||
HOLT, Nicholas Christopher | Amministratore | 1 Dynevor Road TW10 6PF Richmond Upon Thames Surrey | England | British | Director | 10758310003 | ||||
JOYCE, Ian Robert | Amministratore | Meadow Bank Downham Road Chatburn BB7 4AU Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 104330770001 | ||||
KEMP, Mark Andrew | Amministratore | 6 Ibworth Lane GU51 1AU Fleet Hampshire | England | British | Accountant | 90131740004 | ||||
LAWRIE, Edwin John | Amministratore | 25 Downside Road SM2 5HR Sutton Surrey | United Kingdom | British | Company Secretary | 21957820002 | ||||
MASSINGHAM, Terence William | Amministratore | The Triangle Winchester Road SO32 2AJ Durley Hampshire | British | Director | 122371100001 | |||||
MCLELLAN, Colin Warnock | Amministratore | 50 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middlesex | British | Director | 20961750001 | |||||
ROBINSON, Derek Alan | Amministratore | 35 Upper George Street Higham Ferrers NN10 8JN Wellingborough Northamptonshire | British | Building Manager | 28246610001 | |||||
WALLWORK, Paul Anthony Hewitt | Amministratore | Spring Barn Main Street Yarwell PE8 6PR Peterborough Cambridgeshire | British | Company Director | 113014520002 | |||||
WARREN, John | Amministratore | 116 Winton Drive Croxley Green WD3 3QT Rickmansworth Hertfordshire | British | Quantity Surveyor | 28246620001 | |||||
WILDING, Clive Michael | Amministratore | 16 Mill Drove TN22 5AB Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | Director | 32960240002 |
HOMES EXCHANGE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating security document | Creato il 30 set 2004 Consegnato il 05 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first floating charge all its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 apr 1987 Consegnato il 21 mag 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from colroy properties limited to henry ansbacher & co limited on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at biggin lane estate, bury road, ramsey, cambridgeshire. T.N. cb 66805 cb 63796. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal charge | Creato il 23 mag 1986 Consegnato il 27 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge d/d 24/4/86 | |
Brevi particolari Land at the rear of b paks canning factory at bury road ramsey huntingdon cambridgeshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 11 nov 1985 Consegnato il 25 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land part of the pine trees village estate at irthlingborough northamptonshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 set 1985 Consegnato il 11 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that piece or parcel of land situate in gaul road march cambridgeshire and containing six acres and fifteen poles. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 27 set 1985 Consegnato il 02 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 50000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari F/H property being land at the rear of B. paks canning factory bury road ramsey huntingdon cambridgeshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal charge | Creato il 15 mag 1985 Consegnato il 20 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 25/4/85 | |
Brevi particolari F/H - land at ramsey in the district of huntingdon containing 4 1/4 acres or thereabouts. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal charge | Creato il 16 apr 1985 Consegnato il 23 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the legal charge dated 25/04/84. | |
Brevi particolari F/H land at ramsey in the district of huntingdon. (For full details see doc no M65). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 apr 1984 Consegnato il 27 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land comprising approximately 12 1/2 acres off biggin lane, ramsey, huntingdon, cambridge.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 14 dic 1983 Consegnato il 15 dic 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & buildings k/a land at bowbrook road leyland. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 mag 1981 Consegnato il 02 giu 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H cleveleys hydro, chatteris place, cleveleys, blackpool. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 lug 1980 Consegnato il 15 lug 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or colroy homes LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari F/H land at lavendon milton keynes bucks B.M. 62650 forming part of bm 42718. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0