NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED

NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01006878
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED?

    • fabbricazione di supporti magnetici e ottici (26800) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NIMBUS RECORDS LIMITED02 apr 197102 apr 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2020

    10 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Roy Charles Fossett come amministratore in data 15 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2019

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2018

    10 pagineLIQ03

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2017

    9 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU in data 19 set 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 nov 2016

    7 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Resolve Partners Limited One America Square Crosswall London EC3N 2LB a 48 Warwick Street London W1B 5NL in data 01 set 2016

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 16 Great Queen Street Covent Garden London WC2B 5AH a One America Square Crosswall London EC3N 2LB in data 20 nov 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 nov 2015

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 1,517,457
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 feb 2014

    Stato del capitale al 13 feb 2014

    • Capitale: GBP 1,517,457
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roy Charles Fossett il 01 feb 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sophie Ida Jacqueline Le Menaheze il 12 feb 2014

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * Building 1, 3Rd Floor Chiswick Park, 566 Chiswick High Road London W4 5BY* in data 30 gen 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA

    Nomina di Sophie Ida Jacqueline Le Menaheze come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Philippe Andrau come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LE MENAHEZE, Sophie Ida Jacqueline
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    177952080001
    ABDOO, David
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    Segretario
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    British40437090001
    ANDRAU, Philippe
    Rue Dancourt
    75018 Paris
    3
    France
    Segretario
    Rue Dancourt
    75018 Paris
    3
    France
    164739920001
    GUELOT, Sophie
    18 Rue De Roi De Rome
    Rueil Malmaison
    FOREIGN 92500
    Ile De France
    France
    Segretario
    18 Rue De Roi De Rome
    Rueil Malmaison
    FOREIGN 92500
    Ile De France
    France
    French77165180001
    JAIS, Carole Yvonne Marcelle
    Residence Beausoleil
    92210 Saint Cloud
    10
    France
    Segretario
    Residence Beausoleil
    92210 Saint Cloud
    10
    France
    French135325270001
    LEMAIRE, Geraldine Anne
    10-12 Rue De Saigon
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    Segretario
    10-12 Rue De Saigon
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    French95968240001
    MAY, David Alan
    The Firs
    Itton Common
    NP16 6BX Chepstow
    Monmouthshire
    Segretario
    The Firs
    Itton Common
    NP16 6BX Chepstow
    Monmouthshire
    British79256330001
    MOSS, Raymond Alan
    25 Oakleigh Court
    Henllys
    NP44 6HE Cwmbran
    Gwent
    Segretario
    25 Oakleigh Court
    Henllys
    NP44 6HE Cwmbran
    Gwent
    British52116560001
    NASH, Howard Gregory
    10 Laurel Park
    St Arvans
    NP6 6ED Chepstow
    Gwent
    Segretario
    10 Laurel Park
    St Arvans
    NP6 6ED Chepstow
    Gwent
    British18629610001
    ROSS, Aaron Wolfe
    Rue De Miromesnil
    75008 Paris
    78
    France
    Segretario
    Rue De Miromesnil
    75008 Paris
    78
    France
    157517130001
    SMART, Richard John
    66 Footes Lane
    Frampton Cotterel
    BS36 2JG Bristol
    Segretario
    66 Footes Lane
    Frampton Cotterel
    BS36 2JG Bristol
    British50491360002
    APPEL, Gary
    145 East 81st Street
    FOREIGN New York City
    New York 10028
    Usa
    Amministratore
    145 East 81st Street
    FOREIGN New York City
    New York 10028
    Usa
    Us32111710001
    AYRES, Charles
    120 East 79th Street
    New York
    10021
    Usa
    Amministratore
    120 East 79th Street
    New York
    10021
    Usa
    Usa43597840001
    BEHRMAN, Grant
    13 Rolling Hills Lane
    Harrison
    New York
    10528
    Usa
    Amministratore
    13 Rolling Hills Lane
    Harrison
    New York
    10528
    Usa
    Usa43597640001
    DE LEEUW, David
    1130 Park Avenue
    Flat 12-1
    New York
    10128
    Usa
    Amministratore
    1130 Park Avenue
    Flat 12-1
    New York
    10128
    Usa
    Usa43597900001
    DEAN, Thompson
    1172 Park Avenue
    New York
    Ny 10128
    Usa
    Amministratore
    1172 Park Avenue
    New York
    Ny 10128
    Usa
    American58576000001
    DENTON, John
    13 Crooked End Place
    GL17 9YN Ruardean
    Gloucestershire
    Amministratore
    13 Crooked End Place
    GL17 9YN Ruardean
    Gloucestershire
    British18629620001
    DUDEK, Emil James
    18 Bluebell Court
    Ty Canol
    NP44 6JN Cwmbran
    Gwent
    Amministratore
    18 Bluebell Court
    Ty Canol
    NP44 6JN Cwmbran
    Gwent
    British43605910002
    FARMER, Adrian John
    Wyastone Leys
    Ganarew
    NP25 3SR Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Wyastone Leys
    Ganarew
    NP25 3SR Monmouth
    Gwent
    WalesBritish1560610001
    FAULKNER, Lyndon John
    PO BOX 7427
    Charlottesville Virginia 22906
    United States Of America
    Amministratore
    PO BOX 7427
    Charlottesville Virginia 22906
    United States Of America
    British42937430001
    FOSSETT, Roy Charles
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Amministratore
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    EnglandBritish31178620003
    HALLIDAY, Jonathan, Doctor
    Wyastone Leys
    Ganarew
    NP25 3SR Monmouth
    Monmouthshire
    Amministratore
    Wyastone Leys
    Ganarew
    NP25 3SR Monmouth
    Monmouthshire
    British18629600001
    HORSFALL, Timothy Andrew
    1 Llancayo Cottage
    Llancayo
    NP5 1JQ Usk
    Gwent
    Amministratore
    1 Llancayo Cottage
    Llancayo
    NP5 1JQ Usk
    Gwent
    United KingdomBritish54483690001
    LAISTER, Peter
    Thatches
    92 Staines Road Wraysbury
    TW19 5AA Staines
    Middlesex
    Amministratore
    Thatches
    92 Staines Road Wraysbury
    TW19 5AA Staines
    Middlesex
    British11456860001
    MINKEL, Lewis Steven
    PO BOX 7427
    Charlottesville
    Va 22906
    Usa
    Amministratore
    PO BOX 7427
    Charlottesville
    Va 22906
    Usa
    American35661970001
    NASH, Howard Gregory
    St Arvans House
    St Arvans
    NP16 6EY Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    St Arvans House
    St Arvans
    NP16 6EY Chepstow
    Gwent
    British18629610002
    REED, Maureen Kay
    2 Ashwood Close
    NP2 1WT Blackwood
    Gwent
    Amministratore
    2 Ashwood Close
    NP2 1WT Blackwood
    Gwent
    British54428550001
    REYNOLDS, Gerald Alfred John
    Wyastone Leys
    Ganarew
    NP25 3SR Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Wyastone Leys
    Ganarew
    NP25 3SR Monmouth
    Gwent
    United KingdomBritish1560630001
    ROLLASON, William Peter
    23 Waldemar Avenue
    SW6 5LB London
    Amministratore
    23 Waldemar Avenue
    SW6 5LB London
    British67354680002
    SMART, Richard John
    66 Footes Lane
    Frampton Cotterel
    BS36 2JG Bristol
    Amministratore
    66 Footes Lane
    Frampton Cotterel
    BS36 2JG Bristol
    British50491360002
    SMITH, Paul Jeremy, Dr
    18 Willow Place
    Braithwell
    S66 7BD Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    18 Willow Place
    Braithwell
    S66 7BD Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish74597100001
    SWEET, Robert Andrew Inglis
    7 Berkeley Court
    London Road
    GU1 1SN Guildford
    Surrey
    Amministratore
    7 Berkeley Court
    London Road
    GU1 1SN Guildford
    Surrey
    EnglandBritish68267550001
    WARD, Mark
    Thornbury
    Plough Road, Goytre
    NP4 0AL Penperlleni
    Gwent
    Amministratore
    Thornbury
    Plough Road, Goytre
    NP4 0AL Penperlleni
    Gwent
    British97209620001
    WILLIAMS, Lynn
    26 The Maltings
    North Pentwyn
    CF23 8EP Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    26 The Maltings
    North Pentwyn
    CF23 8EP Cardiff
    South Glamorgan
    British72672320001
    WILSON, David
    125 Hickory Grove Drive
    Larchmont
    FOREIGN New York State 10538
    Usa
    Amministratore
    125 Hickory Grove Drive
    Larchmont
    FOREIGN New York State 10538
    Usa
    Us32111700001

    NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 14 nov 1996
    Consegnato il 19 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H property k/a or being unit 50 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • Nationsbank N.A.(As Defined)as Agent and Trustee for Itself and the Lenders
    Transazioni
    • 19 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    All the chattels as detailed in the schedule attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secuerd parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being land and buildings on the east side of william brown close llantarnam park cwmbran gwent t/no WA670323.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H property k/a units 13 19 20 21 & 22 raglan house llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H properties k/a units 51 & 52 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H properties k/a unit 50 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined) and all other obligations covenanted to be paid by the company under clause 14 of the deed of charge
    Brevi particolari
    Land & building to the east side of william brown close llantarnam park cwmbran gwent t/no WA670323 and all the other properties as detailed on the reverse of the form 395 & continuation sheets with all buildings fixtures plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chargee to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 53 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chase manhattan bank,N.A. As agent and trustee ("the security agent") for itself and the lenders (as defined) of nml to the security agent,the agent (as defined) and the lenders under the loan documents (as defined) (including without limitation the guarantee dated 31 march 1995) (as may be amended,restated,supplemented or otherwise modified from time to time)
    Brevi particolari
    Land and building to the east side of william brown close,llantarnam park,cwmbran,gwent.t/no.WA670323.the l/h property k/as units 13,19,20,21 and 22 raglan house,llantarnam park,cwmbran,gwent.the l/h property k/as unit 53 llantarnam park,cwmbran,gwent.the l/h property k/as unit 50 llantarnam park,cwmbran,gwent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of each loan party (as defined) due or to become due to the chase manhattan bank,N.A.as agent and trustee ("the security agent") for itself and the lenders (as defined) together ("the secured parties") or any of them under the loan documents (as defined) whether for amounts drawn under letters of credit or revolving credit guarantees
    Brevi particolari
    Any security or other benefit received or any set-off or counterclaim exercised by nml from or against any loan party.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chase manhattan bank,N.A.as agent and trustee for itself and the lenders (as defined) to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined) including without limitation the guarantee dated 31 march 1995 (as may be amended,testated,supplemented or otherwise modified from time to time)
    Brevi particolari
    The l/h property k/as unit 50 llantarnam park,cwmbran,gwent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chase manhattan bank,N.A. As agent and trustee for itself and the lenders (as defined) to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined) including without limitation the guarantee dated 31 march 1995 (as may be amended,testated,supplemented or otherwise modified from time to time)
    Brevi particolari
    The l/h property k/as unit 53 llantarnam park,cwmbran,gwent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chase manhattan bank,N.A. As agent and trustee for itself and the lenders (as defined) to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined) including without limitation the guarantee dated 31 march 1995 (as may be amended,testated,amended,supplemented or otherwise modified from time to time)
    Brevi particolari
    The l/h property k/as or being units 13,19,20,21 and 22 raglan house,llantarnam park,cwmbran,gwent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chase manhattan bank,N.A. As agent and trustee for itself and the lenders (as defined) to the secured parties (as defined) under the loan documents (as defined) including without limitation the guarantee dated 31 march 1995 (as may be amended,testated,supplemented or otherwise modified from time to time)
    Brevi particolari
    The f/h property k/as or being land and buildings to the east side of william brown close,llantarnam park,cwmbran,gwent.t/no.WA670323.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (as defined in the credit agreement) due or to become due from the company to the chase manhattan bank,N.A. As agent and trustee for itself,and the lenders (as defined)(together "the secured parties") under any of the loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    All that property described in the attached schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1994
    Consegnato il 23 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h property k/a land at unit 50 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1994
    Consegnato il 23 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land at unit 53 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1994
    Consegnato il 23 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at unit 54 llantarnam park cwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 lug 1994
    Consegnato il 03 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Master cutting lathe 9 laser beam recorder model no 5026 serial number 1104126 barclays bank id no.bb-101 and master cutting lathe 10 model no 5025 serial no 1104135 and barclays bank id no bb-102.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Kallfass heat shrink machine 1990 no: KC5040 serial no: 340-872/P1-90-241 and various other chattels as listed on schedule attached to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 03 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Business Credit Inc.
    Transazioni
    • 03 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 02 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 53 llantarnam park cwmbran gwent t/n wa 543848.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 02 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 13,19,20 and 22 raglan house llantarnam parkcwmbran gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 02 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 02 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at llantarnam park cwmbran gwent t/n WA670323.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NIMBUS MANUFACTURING (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 nov 2015Inizio della liquidazione
    13 lug 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Praticante
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Cameron Gunn
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    Praticante
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    Praticante
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0