TRG EMAP DORMANT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRG EMAP DORMANT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01007022 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRG EMAP DORMANT LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TRG EMAP DORMANT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o TOP RIGHT GROUP LIMITED The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRG EMAP DORMANT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CAP MOTOR RESEARCH LIMITED | 20 feb 1995 | 20 feb 1995 |
| CAP NATIONWIDE MOTOR RESEARCH LIMITED | 29 gen 1990 | 29 gen 1990 |
| PROCTER, NOLAN AND PARTNERS LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| CLOCK CAR CENTRES (KEIGHLEY)LIMITED | 06 apr 1971 | 06 apr 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRG EMAP DORMANT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per TRG EMAP DORMANT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Ms Amanda Jane Gradden come amministratore in data 02 gen 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Keith Gulliver come amministratore in data 02 gen 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Greater London House Hampstead Road London NW1 7EJ United Kingdom in data 01 nov 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 ott 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Nomina di Susanna Freeman come segretario in data 24 ott 2012 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Emily Henrietta Gestetner come amministratore in data 29 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di John Keith Gulliver come amministratore in data 11 giu 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed cap motor research LIMITED\certificate issued on 10/04/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Duncan Anthony Painter il 02 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Duncan Anthony Painter come amministratore in data 22 dic 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn John Hindley come amministratore in data 22 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tracey Marie Gray come amministratore in data 21 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di David Gilbertson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Emily Henrietta Gestetner come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRG EMAP DORMANT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEMAN, Susanna | Segretario | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | 173162850001 | |||||||
| LOOI, Shanny | Segretario | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||
| GRADDEN, Amanda Jane | Amministratore | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | England | British | 77425910003 | |||||
| PAINTER, Duncan Anthony | Amministratore | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | England | British | 132649960001 | |||||
| ASHTON, David | Segretario | 336 Skircoat Green Road HX3 0LX Halifax West Yorkshire | British | 58849910001 | ||||||
| DUGMORE, Peter Fawlett | Segretario | 2 Top Meadow WF14 8QA Mirfield West Yorkshire | British | 7830090001 | ||||||
| ELSDON, Kate | Segretario | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Segretario | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
| HAY, Helen Frances | Segretario | The Old Stable Yard Castle Yard Place MK43 7BB Odell Bedfordshire | British | 120089650001 | ||||||
| HENSON, Mark Richard | Segretario | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
| HOGG, Marianne Lisa | Segretario | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | 101383970002 | ||||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Segretario | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| SCOTT, Andrew | Segretario | 18 Sycamore Avenue LS29 0NY Addingham West Yorkshire | British | 5394950001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| ANDERS, Philip William | Amministratore | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | England | British | 42645630003 | |||||
| BARRETT, Charles Martin Richard | Amministratore | Banks Garth 85 Banks Lane Riddlesden BD20 5PE Keighley West Yorkshire | British | 58569440001 | ||||||
| BARROWMAN, Robert Cleland | Amministratore | 69 Grove Road LS29 9PQ Ilkley West Yorkshire | British | 40853380002 | ||||||
| BISSELL, Ian David Raymond | Amministratore | 2 Crescent Road Bletchingley RH1 4RB Redhill Surrey | British | 80845030001 | ||||||
| BROWN, Philip | Amministratore | Greydene Station Road, Woldingham CR3 7DD Caterham Surrey | United Kingdom | British | 70412460002 | |||||
| CARTER, Derek Raymond Anthony | Amministratore | Pinewych Vigo Road Fairseat TN15 7LR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 29959930002 | |||||
| CARTER, Derek Raymond Anthony | Amministratore | Pinewych Vigo Road Fairseat TN15 7LR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 29959930002 | |||||
| ELLIOT, Richard Emmerson | Amministratore | Orchard House 2 Richardson Close, Mill Drove PE10 9YN Bourne Lincolnshire | United Kingdom | British | 40591070005 | |||||
| GESTETNER, Emily Henrietta | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 138386390001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| GOUGH, Malcolm Howard | Amministratore | South Lodge Fineshade Abbey Fineshade NN17 3BA Corby Northamptonshire | United Kingdom | British | 124396590001 | |||||
| GRAY, Tracey Marie | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 130960400002 | |||||
| GRIFFIN, Ian Richard | Amministratore | 5 Varsity Row Thames Bank SW14 7SA London | England | British | 94720930001 | |||||
| GRIFFITHS, Ian Ward | Amministratore | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | United Kingdom | British | 99547790001 | |||||
| GULLIVER, John Keith | Amministratore | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | United Kingdom | British | 170112360001 | |||||
| HILL, Walter Gordon | Amministratore | Croft House Knotty Lane Lepton HD8 0ND Huddersfield | British | 5394970001 | ||||||
| HINDLEY, Martyn John | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 134332760002 | |||||
| JACKSON, Nicholas Francis | Amministratore | 167 Foxcroft Drive HD6 3UP Brighouse West Yorkshire | British | 40853360001 | ||||||
| KEANE, Rupert Anthony | Amministratore | Arch Cottage Burford Street GL7 3AR Lechdale Glos | British | 106929210001 | ||||||
| KEENAN, Paul | Amministratore | 19 Church Crescent Muswell Hill N10 3NA London | England | British | 39692770003 | |||||
| MCALEENAN, Patrick David | Amministratore | 78 Hazlewell Road Putney SW15 6UR London | England | British | 14226510001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0