ISOFT EUROPE LIMITED

ISOFT EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISOFT EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01007428
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISOFT EUROPE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ISOFT EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISOFT EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOREX LIMITED14 set 200414 set 2004
    TOREX GROUP PLC11 apr 199611 apr 1996
    TOREX HIRE PLC01 mag 197301 mag 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISOFT EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ISOFT EUROPE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ISOFT EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2014

    Stato del capitale al 14 apr 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2013 al 30 set 2013

    3 pagineAA01

    Cessazione della carica di Andrew Thomson come amministratore

    2 pagineTM01

    Stato del capitale al 24 giu 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Nomina di David William Hart Gray come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gareth Wilson come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Adrian Stevens come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2012 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrea Fiumicelli il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew James Edward Thomson il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Adrian Charles Stevens il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Gareth Antony Wilson il 12 set 2011

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* in data 18 ago 2011

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* in data 05 ago 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di ISOFT EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357970001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    BLOWER, Jonathan Morgan
    Silverwood Cummings Cross
    Liverton
    TQ12 6HS Newton Abbot
    Devon
    Segretario
    Silverwood Cummings Cross
    Liverton
    TQ12 6HS Newton Abbot
    Devon
    British7592170002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Segretario
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    MITCHELL, Clive Sidney
    Riddon Brake
    Postbridge
    PL20 6TR Yelverton
    Devon
    Segretario
    Riddon Brake
    Postbridge
    PL20 6TR Yelverton
    Devon
    British112788520001
    TELFER, Robert
    16 Prestonwood
    Tynemouth
    NE30 3LT Tyne & Wear
    Tyne & Wear
    Segretario
    16 Prestonwood
    Tynemouth
    NE30 3LT Tyne & Wear
    Tyne & Wear
    British46983760001
    WHELLER, Kevin John
    64 Rollestone Crescent
    Pennsylvania
    EX4 5EF Exeter
    Devon
    Segretario
    64 Rollestone Crescent
    Pennsylvania
    EX4 5EF Exeter
    Devon
    BritishAccountant41518220001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162049540001
    BLOWER, Jonathan Morgan
    Silverwood Cummings Cross
    Liverton
    TQ12 6HS Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Silverwood Cummings Cross
    Liverton
    TQ12 6HS Newton Abbot
    Devon
    BritishManaging Director7592170002
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Amministratore
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    COWELL, Peter David
    Cherbury House Charney Road
    Longworth
    OX13 5HW Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Cherbury House Charney Road
    Longworth
    OX13 5HW Abingdon
    Oxfordshire
    BritishCompany Director6047780002
    DAY, Robert William
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector66520250001
    DIXON, Alan
    40 Copythorne Road
    TQ5 8PX Brixham
    Devon
    Amministratore
    40 Copythorne Road
    TQ5 8PX Brixham
    Devon
    BritishCompany Director25752180001
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Amministratore
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    HOGARTY, Martin John
    Littleham
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Littleham
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director61700350001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    LEAVY, Nigel Edward
    Boot Cottage
    Boot Street Stonesfield
    OX29 8PX Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    Boot Cottage
    Boot Street Stonesfield
    OX29 8PX Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant38639910001
    LONGRIGG, Benjamin Hugh Hemsley
    Oaklands
    Stoke-In-Teignhead
    TQ12 4QJ Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Oaklands
    Stoke-In-Teignhead
    TQ12 4QJ Newton Abbot
    Devon
    United KingdomBritishChairman7592180001
    LOOSEMORE, Robert William
    Wildwood
    Bourton Road
    OX18 2PB Clanfield
    Oxfordshire
    Amministratore
    Wildwood
    Bourton Road
    OX18 2PB Clanfield
    Oxfordshire
    BritishDirector59209820001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MITCHELL, Clive Sidney
    Riddon Brake
    Postbridge
    PL20 6TR Yelverton
    Devon
    Amministratore
    Riddon Brake
    Postbridge
    PL20 6TR Yelverton
    Devon
    EnglandBritishCompany Director112788520001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director34428100003
    O'CALLAGHAN, John Patrick
    11 Pemberley Avenue
    MK40 2LE Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    11 Pemberley Avenue
    MK40 2LE Bedford
    Bedfordshire
    IrishCompany Director5721130001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director57516220003
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Amministratore
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    TELFER, Robert
    16 Prestonwood
    Tynemouth
    NE30 3LT Tyne & Wear
    Tyne & Wear
    Amministratore
    16 Prestonwood
    Tynemouth
    NE30 3LT Tyne & Wear
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director46983760001
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    THORPE, David Allan
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director77702540001
    WALL, Colin David, Dr
    The Granary
    Stamford Road
    PE6 9JD West Deeping
    Stamford
    Amministratore
    The Granary
    Stamford Road
    PE6 9JD West Deeping
    Stamford
    United KingdomBritishDirector33732850002

    ISOFT EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Agreement on the assignment
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 15 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the finance parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assignor assigns under the security agreement for security purposes all of the claims to the security agent. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 13 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks,debentures,bonds,warrants,coupons or other securities and investments see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security amendment agreement
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 13 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the claims in connection with any loan granted to any group company see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N V Acting as Security Trustee Under German Law for the Finance Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security amendment agreement
    Creato il 30 lug 2008
    Consegnato il 15 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the claims of the company in connection with any loan granted to any other group company, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An agreement on the assignment of claims under intercompany loans
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 27 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the claims being any claim of the assignor arising from or in connection with any loan granted. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 27 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of accession
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Creato il 13 apr 2006
    Consegnato il 28 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 01 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any other of the parent company's subsidiaries (together the group) to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property known as unit 2 firecrest court warrington t/no CH445922, l/h property known as upminster unit 16 essex, l/h property known as sarum gate basingstoke t/no HP208786. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the rentalincome, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts and other debts.floating charge all undertaking and all. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 21 lug 2003
    Consegnato il 06 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property known as churchfields, stonesfield, witney OX8 8PQ t/no ON214941 and all that f/h property known as unit 2 (postal number 310) firecrest court, centre park, warrington, cheshire, t/no CH445922. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Securedparties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    Creato il 08 ago 2002
    Consegnato il 16 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    Creato il 08 ago 2002
    Consegnato il 16 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second fixed and floating security document (the "second security document") dated 6TH september 2001 between the company,certain other chargors as listed in the second security document (together the "chargors") and lloyds tsb bank capital markets in it's capacity as security trustee for the secured parties
    Creato il 06 set 2001
    Consegnato il 18 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due by any chargor to any secured party under or in connection with any secured document including under the amended and restated facility agreement
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC, Capital Markets
    Transazioni
    • 18 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 06 ago 2001
    Consegnato il 09 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document between the company, certain other chargors as listed in the security document (together the chargors) and lloyds tsb bank PLC, capital markets in its capacity as security trustee for the secured parties (as defined)
    Creato il 28 dic 2000
    Consegnato il 03 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any chargor to any secured party under or in connection with any secured document (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC, Capital Markets
    Transazioni
    • 03 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of pledge of registered shares in torex health nederland B.V.
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 04 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    All the issued shares in the capital of the company together with voting rights and shareholders rights which includes dividends and other distributions from the company's equity and rights to subscribe for otherwise acqure shares in the company's capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 nov 1999
    Consegnato il 26 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2 (postal number 310), firecrest court centre park warrington cheshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 22 lug 1999
    Consegnato il 26 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as churchfields,stonesfield witnet oxon OX8 8PQ. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 73/77 hendford hill yeovil somerset t/no. ST133920 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 1 woodland business park torquay devon t/no.DN28830 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 89/95 newton road torquay devon t/no.DN41967 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lower moor tiverton devon t/no.DN238620 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H wellington road taunton somerset t/no.STL53835 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at gover road st austell cornwall t/no.CL57730 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 gen 1997
    Consegnato il 11 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 96/102 ridgway plympton plymouth devon t/nos.DN149430 and DN123444 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0