GNI LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGNI LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01007530
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GNI LIMITED?

    • (6523) /

    Dove si trova GNI LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GNI LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTER COMMODITIES LIMITED08 apr 197108 apr 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di GNI LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GNI LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GNI LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 lug 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 lug 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 lug 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2012

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 62 Wilson Street London EC2A 2BU* in data 30 set 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 lug 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2011

    5 pagine4.68

    Cessazione della carica di Stephen Harragan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Karel Harbour come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Karel Harbour come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Avey come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Avey come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6DU* in data 28 gen 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 gen 2010

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di GNI LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GEORGE, Sonia Jane
    Princes Avenue
    N22 7SA London
    16
    England
    United Kingdom
    Segretario
    Princes Avenue
    N22 7SA London
    16
    England
    United Kingdom
    British125196240002
    COCHRANE, Stephen Robert
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Segretario
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    British40052090002
    WAKEFIELD, Barry John
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    Segretario
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    British27554930001
    WALLIS, Nicholas Charles
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    British4190770001
    WOYDA, Jeffrey David
    Partingdale Manor
    Partingdale Lane Mill Hill
    NW7 1NS London
    Segretario
    Partingdale Manor
    Partingdale Lane Mill Hill
    NW7 1NS London
    British116885950001
    ADLER, Philip Howard
    16 Staverton Road
    NW2 5HL London
    Amministratore
    16 Staverton Road
    NW2 5HL London
    British70968440002
    ARNOWITZ, Larry Harris
    452 Ellridge Circle
    Highland Park 60035 Illinois
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    452 Ellridge Circle
    Highland Park 60035 Illinois
    FOREIGN Usa
    American46786860001
    AVEY, Nigel Anthony Bruce
    2 Green Trees
    Ambleside
    CM16 4QT Epping
    Essex
    Amministratore
    2 Green Trees
    Ambleside
    CM16 4QT Epping
    Essex
    EnglandBritish46157050002
    BOARDMAN, Guy Alexander
    86a Priests Lane
    Shenfield
    CM15 8HQ Brentwood
    Essex
    Amministratore
    86a Priests Lane
    Shenfield
    CM15 8HQ Brentwood
    Essex
    British30748220002
    BOULTON, Paul
    17 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    British38532730001
    BRAYSHAW, David Arthur
    25 Avenue Road
    CM23 5NT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    25 Avenue Road
    CM23 5NT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish119697400001
    BREISLIN, Richard John Henry
    9 Blackthorn Close
    AL4 9RP St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Blackthorn Close
    AL4 9RP St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish167444170001
    BURRIDGE, John Grey St Paul
    The Manor House
    Brixton Deverill
    BA12 7EJ Warminster
    Wiltshire
    Amministratore
    The Manor House
    Brixton Deverill
    BA12 7EJ Warminster
    Wiltshire
    United KingdomBritish3718420003
    CANWELL, Stuart
    Springfield House
    22 Springfield Grove
    TW16 6NT Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    Springfield House
    22 Springfield Grove
    TW16 6NT Sunbury On Thames
    Middlesex
    British141825210001
    CARLISLE, Euan N
    20 Lancaster Road
    SW19 5DD Wimbledon Village
    London
    Amministratore
    20 Lancaster Road
    SW19 5DD Wimbledon Village
    London
    United KingdomBritish108880850001
    CAVALLA, Nicholas Mark
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    Amministratore
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    United KingdomBritish84381380001
    COCHRANE, Stephen Robert
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish40052090002
    CONQUEST, Simon
    7 Malden Park
    KT3 6AS New Malden
    Surrey
    Amministratore
    7 Malden Park
    KT3 6AS New Malden
    Surrey
    British75258750001
    CRAMER, Patrick
    La Musardiere
    Chemin De Ropre
    1135 Denens
    Switzerland
    Amministratore
    La Musardiere
    Chemin De Ropre
    1135 Denens
    Switzerland
    Swiss52500640001
    DAVIES, Mark Edward Trehearne
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    Amministratore
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    EnglandBritish82536300001
    DAVIES, Stephen Arthur James
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    British73623020001
    DAVIES, Tony
    50 Worcester Crescent
    IG8 0LS Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    50 Worcester Crescent
    IG8 0LS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish44889680002
    DAVIS, Kevin Roger
    Apartment 10e 271 Central Park West
    New York
    Ny 10024
    Usa
    Amministratore
    Apartment 10e 271 Central Park West
    New York
    Ny 10024
    Usa
    British49328960008
    DIBBEN, Piers Farquhar
    Trinity Farm
    Rodbourne
    SN16 0EX Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Trinity Farm
    Rodbourne
    SN16 0EX Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish65358540002
    DIZER, Chris
    37 Compton Road
    SW19 7QA London
    Amministratore
    37 Compton Road
    SW19 7QA London
    British62902240001
    DOBELL, Charles Mark Johnson
    63 Lauderdale Tower
    EC2Y 8BY London
    Amministratore
    63 Lauderdale Tower
    EC2Y 8BY London
    British83017500001
    EWEN, Malcolm Henry Stanley
    Wash Farm
    Ferneaux Pelham
    SG9 0JX Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Wash Farm
    Ferneaux Pelham
    SG9 0JX Buntingford
    Hertfordshire
    British37441860001
    FELLOWES, Thomas William
    The Old Rectory
    Barking
    IP6 8HH Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    The Old Rectory
    Barking
    IP6 8HH Ipswich
    Suffolk
    British9854990001
    FEW BROWN, Benjamin Geoffrey
    Ashe House
    Cholderton Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Ashe House
    Cholderton Salisbury
    Wiltshire
    British46157470001
    FISHER, Marc Anthony
    7 Rangeworth Place
    DA15 7JE Sidcup
    Kent
    Amministratore
    7 Rangeworth Place
    DA15 7JE Sidcup
    Kent
    British75258780001
    FLETCHER, Piers Michael William
    Blackberry Farm Winterslow
    SP5 1QP Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Blackberry Farm Winterslow
    SP5 1QP Salisbury
    Wiltshire
    British12056130007
    FOX, Noel
    Inglenook
    Rectory Road,
    RM16 3EH Orsett
    Essex
    Amministratore
    Inglenook
    Rectory Road,
    RM16 3EH Orsett
    Essex
    British88626290001
    FRIEDLOS, Stephen Michael
    Clifford House
    Christmas Hill
    GU4 8HP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Clifford House
    Christmas Hill
    GU4 8HP Guildford
    Surrey
    EnglandBritish82802310001
    GANT, Nicholas
    184a Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    Amministratore
    184a Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    British75259390001
    GORMAN, Marcus Samuel
    Old Priors
    Shermanbury Road
    RH13 8EU Partridge Green
    West Sussex
    Amministratore
    Old Priors
    Shermanbury Road
    RH13 8EU Partridge Green
    West Sussex
    British75491280001

    GNI LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Memorandum of pledge for deposits on time deposits and other account balances
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 03 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present future and conditional claims which dresdner bank ag with all its domestic and foreign branches is entitled as a result of the banking relationship against the company where the company has assumed liability for the obligations of another customer of dresdner bank ag (E.G. as guarantor)
    Brevi particolari
    All the balances and deposits which the company maintains at present and in future on accounts 4990804794720 together with interest at dresdner bank ag.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 03 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 19 nov 2001
    Consegnato il 28 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security deed
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security dty deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or held on behalf of or otherwise referable to the company in crest ost or any transfer by the company of any of its right title or interest to and I n stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account in crest together with all rights and interests in such sums and payments.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 04 gen 2001
    Consegnato il 22 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility agreement and/or the security deed or any of the other documentation as defined therein
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the company, by way of first floating charge all eligible stock held by or on behalf of or for the account of the company in crest.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 05 lug 2000
    Consegnato il 17 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilties due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security deed
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or held on behalf of or otherwise referable to the company in crest or any transfer by the company of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account in crest together with all rights and interests in such sums and payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 29 giu 2000
    Consegnato il 30 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilties due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security deed
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or held on behalf of or otherwise referable to the company in crest or any transfer by the company of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account in crest together with all rights and interests in such sums and payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transazioni
    • 30 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 18 mag 2000
    Consegnato il 26 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A security interest in and a lien upon all personal propertyn and fixtures of the debtor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York
    Transazioni
    • 26 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Memorandum of pledge
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 18 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the memorandum of pledge
    Brevi particolari
    All balances and deposits plus interest on the following time deposits no. 499 08 047 94700 and other account balances under the no.499 08 047 94702.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 18 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of pledge
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 18 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the memorandum of pledge
    Brevi particolari
    All balances and deposits plus interest on the following time deposits no. 499 08 047 94700 and other account balances under the no.49908047 94700.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 18 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security deed (supplemental to a security deed dated 14 november 1997 as amended by a further deed dated 15 january 1999)
    Creato il 21 mag 1999
    Consegnato il 27 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever which arise out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Brevi particolari
    All sums and payments on the date of the security deed to be represented by any credit balance on any such eligible account and all monies standing to the credit of the controlled accounts by way of floating charge all eligible stock ,all property rights or interests of the company to eligible stock on the cgo service and all other sums and benefits please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of England
    Transazioni
    • 27 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed in connection with the original security deed dated 10TH november 1997
    Creato il 15 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever arising out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities
    Brevi particolari
    All sums and payments on the date of the security deed to be represented by any credit balance on any such eligible account and all monies standing to the credit of the controlled accounts by way of floating charge all eligible stock ,all property rights or interests of the company to eligible stock on the cgo service and all other sums and benefits please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security deed
    Creato il 08 giu 1998
    Consegnato il 16 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation liabilities which arise out of or in connection with the provision by the bank to the company of crest settlement bank facilities) including all interest, costs and other charges whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all sums and payments receivable by the company in crest and all monies standing to the credit of the controlled accounts. By way of first floating charge all eligible stock held by or for the account of the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 14 nov 1997
    Consegnato il 14 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever which arise out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Brevi particolari
    All sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or fro the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit, stock from any eligible stock account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transazioni
    • 14 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplement to collateral agreement
    Creato il 22 lug 1996
    Consegnato il 09 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts due or to become due from the company to the chargee referred to in section 4(a) of the collateral agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to accounts 42 000 1X yyy/99907. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 09 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Custody agreement
    Creato il 17 ago 1995
    Consegnato il 21 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All the cash from time to time in the cash account and all the shares stocks bonds notes debentures or other securities held for the account of the company.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    • Jp Morgan S.P.A.
    Transazioni
    • 21 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1995
    Consegnato il 06 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a banking services agreement or this deed (as defined in the legal charge)
    Brevi particolari
    First fixed charge over all sums for the time being, first floating charge over all the right title and interest of the company, stock and other securities, any other interest conferred or to be conferred by such credit balance and any stock and other securities of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transazioni
    • 06 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplement to collateral agreement
    Creato il 03 nov 1994
    Consegnato il 11 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the company's use of the euroclear system
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in and to account no. 93905 opened by morgan guaranty brussels in the name of the company or such other account as may be agreed by the borrower and morgan guaranty brussels (the "pledged account"), including any credit balance which may appear therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 11 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral agreement
    Creato il 03 nov 1994
    Consegnato il 11 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the company's use of the euroclear system
    Brevi particolari
    All "collateral" including but not limited to cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of the chargee on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 11 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 07 ott 1983
    Consegnato il 10 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit balance of £500,000 held with williams & glyn's bank PLC together with all interest accrued or accuring thereon.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 15 lug 1981
    Consegnato il 16 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit balance of £50,000 held with williams & glyns bank limited together with all interest.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GNI LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 gen 2010Inizio della liquidazione
    29 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon James Underwood
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    Praticante
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0