B.D.L. SYSTEMS LIMITED

B.D.L. SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàB.D.L. SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01017495
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di B.D.L. SYSTEMS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova B.D.L. SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di B.D.L. SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per B.D.L. SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 31 ago 2023

    • Capitale: GBP 0.10
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel redemption reserve 21/08/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2022

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Michael Edward Luedicke come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di B.D.L. SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Segretario
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    DAVIES, Michael John
    Flambards Arrowsmith Road
    BH21 3BE Wimborne
    Dorset
    Segretario
    Flambards Arrowsmith Road
    BH21 3BE Wimborne
    Dorset
    British21790880001
    DAVIES, Simon
    Flambards
    Arrowsmith Road
    BH21 3BE Canford Magna
    Dorset
    Segretario
    Flambards
    Arrowsmith Road
    BH21 3BE Canford Magna
    Dorset
    British97533930001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    CLASBY, Alan Frederick
    20 Moor Road
    BH18 8BB Broadstone
    Dorset
    Amministratore
    20 Moor Road
    BH18 8BB Broadstone
    Dorset
    EnglandBritish20904700001
    DAVIES, Michael John
    Flambards Arrowsmith Road
    BH21 3BE Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    Flambards Arrowsmith Road
    BH21 3BE Wimborne
    Dorset
    British21790880001
    DAVIES, Simon Michael
    Hightown Hill
    BH24 3HQ Ringwood
    Foulford Farm
    Hampshire
    Amministratore
    Hightown Hill
    BH24 3HQ Ringwood
    Foulford Farm
    Hampshire
    EnglandBritish97533930002
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    HELME, Michael John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish91910030002
    HILL, Robert Seamus
    Cherming House
    1500 Parkway Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Cherming House
    1500 Parkway Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    EnglandBritish59194350003
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish57563390001
    LUEDICKE, Michael Edward
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish172196070001
    MCDONALD, David Alexander
    Cherming House
    1500 Parkway Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Cherming House
    1500 Parkway Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritish163520170001
    MOORE, John Jeremy, Major General Sir
    Melbourne House
    Bratton
    BA13 4RL Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Melbourne House
    Bratton
    BA13 4RL Westbury
    Wiltshire
    British7659750001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    PRIDMORE, Peter Ian
    6 Mountbatten Square
    Southsea
    PO4 9XY Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    6 Mountbatten Square
    Southsea
    PO4 9XY Portsmouth
    Hampshire
    British121877680001
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    WALKER, John Robert, Sir
    4 Telford's Yard
    E1W 2BQ London
    Amministratore
    4 Telford's Yard
    E1W 2BQ London
    British92672010001
    WILLIAMS, Steven Geoffery
    50 Woodlea Road
    BN13 1BN Worthing
    Sussex
    Amministratore
    50 Woodlea Road
    BN13 1BN Worthing
    Sussex
    British105948690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di B.D.L. SYSTEMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 giu 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1528540
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    B.D.L. SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 set 2010
    Consegnato il 13 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 30 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 nov 2007
    Consegnato il 20 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Noteholders and the Purchasers)
    Transazioni
    • 20 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 nov 2006
    Consegnato il 30 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 30 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 apr 2006
    Consegnato il 20 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 08 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H proerty being land at blackhill road holton heath poole dorset.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £550,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at blackhill road holton heath poole dorset t/n DT307552.
    Persone aventi diritto
    • Foselle Estates (Developments) Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2002
    Consegnato il 20 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 08 nov 1999
    Consegnato il 10 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due or to become due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    A debenture by way of legal charge over the assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of Bdl Systems Limited Retirement Benefits Scheme
    Transazioni
    • 10 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 16 ago 1999
    Consegnato il 26 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement.account number 7404617.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 05 dic 1996
    Consegnato il 11 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all the equipment and vehicles as follows panasonic uf 280M fax machine 03916904, peripherique 16MB upgrade thinkpad 760 01954006 69-760-160, apex clippercom V34 modem card 03714906 PCMC1A, thinkpad 760 mode cdw cdw 760DWUK, centrex KL486 d x 2-66 00673704 mtmm+kb ENHA10527 see reverse of form 395 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 apr 1996
    Consegnato il 24 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Sum of up to £122000 standing or to the credit of an account designated bdl systems limited with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counter indemnity
    Creato il 24 nov 1995
    Consegnato il 08 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and obligations payable from the company to the chargee in respect of a tender bond for 480,000,000 italian lira given to centro technico genco militare by banca nazionale del lavoro pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    The sum of up to £155,000 standing in or to the credit of an account designated bdl systems limited with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 25 nov 1989
    Consegnato il 04 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counter indemnity & charge
    Creato il 24 gen 1985
    Consegnato il 12 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £62,275 standing in or to be credited to a designated account and all interest due in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 20 dic 1979
    Consegnato il 03 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises 14 denmark lane, wimbourne road, poole, dorset together with fixtures whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank LTD
    Transazioni
    • 03 gen 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0