W.H. FLUIDPOWER LIMITED

W.H. FLUIDPOWER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàW.H. FLUIDPOWER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01019281
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di W.H. FLUIDPOWER LIMITED?

    • (5190) /

    Dove si trova W.H. FLUIDPOWER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di W.H. FLUIDPOWER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WIRRAL HYDRAULICS LIMITED30 lug 197130 lug 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di W.H. FLUIDPOWER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per W.H. FLUIDPOWER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr James Hugh Ellis-Rees come segretario in data 15 set 2011

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Alexandra Mary Jane Vaizey come amministratore in data 15 set 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alexandra Mary Jane Vaizey come segretario in data 15 set 2011

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr James Hugh Ellis-Rees come amministratore in data 15 set 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 02 gen 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2011

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2011

    Stato del capitale al 09 mar 2011

    • Capitale: GBP 13,502,515
    SH01

    Bilancio redatto al 01 gen 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2010

    14 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Alexandra Mary Jane Vaizey il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per William Robert Banks il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Alexandra Mary Jane Vaizey il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 02 gen 2009

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 28 dic 2007

    18 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di W.H. FLUIDPOWER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS-REES, James Hugh
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    163268380001
    BANKS, William Robert
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish31507290001
    ELLIS-REES, James Hugh, Mr.
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritish156071390001
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Segretario
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    British1227500001
    RILEY, Joseph Kenneth Michael
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    Segretario
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    British154381500001
    STEVENS, David Alexander
    Lilac Cottage Neston Road
    Willaston
    L64 2TF South Wirral
    Merseyside
    Segretario
    Lilac Cottage Neston Road
    Willaston
    L64 2TF South Wirral
    Merseyside
    British23293520001
    VAIZEY, Alexandra Mary Jane
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    British83460130003
    AIKEN, William John, Mr.
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritish40553130001
    BOYD, John Leonard
    2 Meadow Ridge
    Hatch Warren
    RG22 4QH Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    2 Meadow Ridge
    Hatch Warren
    RG22 4QH Basingstoke
    Hampshire
    British32693530002
    CURSON, Paul Nigel
    The Flint Barn 6 Upper House Farm
    Woodlands, Bramdean
    SO24 0HW Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    The Flint Barn 6 Upper House Farm
    Woodlands, Bramdean
    SO24 0HW Alresford
    Hampshire
    British67639640001
    DAVIES, Antony Robert
    1 Salisbury Avenue
    West Kirby
    L48 0QL Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    1 Salisbury Avenue
    West Kirby
    L48 0QL Wirral
    Merseyside
    British23293540001
    ENTWISTLE, John Edward
    80 Highfield Road
    WA13 0EE Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    80 Highfield Road
    WA13 0EE Lymm
    Cheshire
    British6277860001
    FROST, Paul Douglas
    Links Edge 5 Cornfield Road
    Romiley
    SK6 4LU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Links Edge 5 Cornfield Road
    Romiley
    SK6 4LU Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish9386150003
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritish1227500001
    LACEY, Ian Thomas
    19 Brookhurst Avenue
    Broomborough
    L63 0HR Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    19 Brookhurst Avenue
    Broomborough
    L63 0HR Wirral
    Merseyside
    British23293530002
    MUNNELLY, Peter James
    10 The Paddock
    Elton
    CH2 4PT Chester
    Cheshire
    Amministratore
    10 The Paddock
    Elton
    CH2 4PT Chester
    Cheshire
    British23293550001
    RILEY, Joseph Kenneth Michael
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    Amministratore
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    EnglandBritish154381500001
    STEVENS, David Alexander
    Lilac Cottage Neston Road
    Willaston
    L64 2TF South Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Lilac Cottage Neston Road
    Willaston
    L64 2TF South Wirral
    Merseyside
    British23293520001
    VAIZEY, Alexandra Mary Jane
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish83460130003

    W.H. FLUIDPOWER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 06 ago 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) LTD
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 2002
    Consegnato il 13 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ups Capital UK LTD
    Transazioni
    • 13 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge over all assets
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 27 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    F/H and l/h property present and future and all buildings and fixtures, all shares and securities whatsoever held by the company together with all rights benefits and advantages all moneys payable to the company and all other rights the company may have under a business finance agreement dated 12 march 2001...all right title property and interest (if any) that the company may have in and to the debts and to the related rights.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 27 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite guarantee and debenture ( the "deed")
    Creato il 30 mar 2001
    Consegnato il 12 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the company to the chargee the beneficiaries or any of them under or in connection with the loan note instrument (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 12 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mar 1997
    Consegnato il 03 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First fixed charge
    Creato il 29 ott 1993
    Consegnato il 04 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on book debts and other debts present and future and the proceeds thereof as are not sold to and bought by alex lawrie receivables financing limited under the terms of an agreement dated 29/10/93. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 04 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 dic 1980
    Consegnato il 05 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1155 new chester road, eastham wirral merseyside title no ms 45235 1157 new chester road, eastham, wirral, merseyside title no ms 64129 specific equitable charge over all f/h & l/h properties ficed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book-debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0