GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01019505 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GARTLAND WHALLEY AND BARKER PLC | 12 set 1996 | 12 set 1996 |
| SELECT INDUSTRIES PLC | 05 mar 1991 | 05 mar 1991 |
| COURTWELL GROUP PLC | 19 feb 1990 | 19 feb 1990 |
| BEAR BRAND PLC | 15 lug 1988 | 15 lug 1988 |
| TRANWOOD GROUP P L C | 02 ago 1971 | 02 ago 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 12 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Tenco Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 16 feb 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 dic 2021 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Tenco Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 09 set 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 City Square Leeds LS1 2AL a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 02 lug 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da West House, Kings Cross Road Halifax West Yorkshire HX1 1EB a 1 City Square Leeds LS1 2AL in data 10 feb 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Whalley come amministratore in data 17 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Gartland come amministratore in data 29 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 16 pagine | AAMD | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEATHER, Brian Hersee | Segretario | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | British | 40164810001 | ||||||
| BOND, Kimberley Jane | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | 129298420003 | |||||
| GARTLAND, Daniel Justin | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | England | British | 76219110005 | |||||
| GARTLAND, Deborah Louise | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | 131545080001 | |||||
| HEATHER, Brian Hersee | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | 40164810001 | |||||
| JACKSON, Kelly Anne | Amministratore | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | 89909090004 | |||||
| BARKER, James Edward | Segretario | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | British | 42890001 | ||||||
| BENNETT, Phillip James | Segretario | Grove House Daw Lane Horbury WF4 5DR Wakefield West Yorkshire | British | 113393520001 | ||||||
| DUDGEON, James Alexander | Segretario | 8/9 Lambton Place W11 2SH London | British | 46460760001 | ||||||
| BARKER, James Edward | Amministratore | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | United Kingdom | British | 42890001 | |||||
| BENNETT, Phillip James | Amministratore | Grove House Daw Lane Horbury WF4 5DR Wakefield West Yorkshire | England | British | 113393520001 | |||||
| BURNS, Alan Robert | Amministratore | 5 Charterhouse Square EC1M 6EE London | British & Australian | 56546290003 | ||||||
| CARSLAKE, Stanley Albert William | Amministratore | Monkhams Half Acres CM23 2QP Bishops Stortford Hertfordshire | British | 18073490001 | ||||||
| CLARKE, Bryan | Amministratore | 5152 Brooke Farm Drive FOREIGN Atlanta Georgia 30338 Usa | British | 67148600001 | ||||||
| CROSSLEY, Ralph John, Major General | Amministratore | Old Orchard Harthill Drove, Redlynch SP5 2HR Salisbury Wiltshire | British | 66724270002 | ||||||
| DOWLAND, Graham Rochford | Amministratore | 22 Fernshaw Road SW10 0TF London | Australian | 61833670001 | ||||||
| DUDGEON, James Alexander | Amministratore | 8/9 Lambton Place W11 2SH London | British | 46460760001 | ||||||
| GARTLAND, Anthony | Amministratore | West House, Kings Cross Road Halifax HX1 1EB West Yorkshire | United Kingdom | British | 27652170001 | |||||
| HELBY, Andrew | Amministratore | Walnut Tree Cottage Main Road Appleford OX14 4PF Abingdon Oxfordshire | British | 46275660001 | ||||||
| KING OF WARTNABY, John Leonard, The Lord | Amministratore | Friars Well Wartnaby L14 3HY Melton Mowbray Leicestershire | British | 30236640002 | ||||||
| MARSH, Derick | Amministratore | 137 Linden Tree Road Wilton Ct06897 Usa | British | 81930900002 | ||||||
| RAYNAUD, Simon | Amministratore | 4 Halland Way HA6 2AG Northwood Middlesex | British | 70707700001 | ||||||
| SNOOK, Kevin Lee | Amministratore | 28 Nanton Avenue FOREIGN Toronto Ontario M4w 2y9 Canada | Canadian | 18073540001 | ||||||
| STEINEPREIS, David Christian | Amministratore | 62 Leake Street Peppermint Grove Perth Western Australia 6011 Australia | Australia | Australian | 75310460001 | |||||
| STEWART, Jonathan Kingsley | Amministratore | 59 Park Walk SW10 0AZ London | Australian | 43955960002 | ||||||
| STEWART, Jonathan Kingsley | Amministratore | 1 Sea View Terrace Cottesloe Western Australia Australia | Australian | 20457530001 | ||||||
| VANDYK, Edward | Amministratore | The Old Vicarage Sutton Courtenay OX14 4NJ Abingdon Oxon | British | 65877700001 | ||||||
| WHALLEY, Jeffrey | Amministratore | West House, Kings Cross Road Halifax HX1 1EB West Yorkshire | United Kingdom | British | 1955430002 | |||||
| WHITE, Lesley Ann | Amministratore | 13 Neville Road Ealing W5 1NN London | British | 60816790001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 29 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 12 mag 2009 Consegnato il 21 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 09 gen 2009 Consegnato il 15 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shares charge | Creato il 22 gen 2004 Consegnato il 30 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage the shares, all stocks shares securities rights money or property accruing in respect of any of the shares, by way of assignment all rights relating to the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of pledge over shares | Creato il 22 set 2000 Consegnato il 10 ott 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 3,150,000 ordinary shares in e-quisitor PLC plus any bonuses interest dividend or other benefits. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 04 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £33,676,287 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari The whole of the undertaking, property, rights and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 04 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over all undertaking property and assets of the company present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of pledge | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 04 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 7,440,053 ordinary shares in quadramatic PLC, 6,500,040 ordinary shares independent part group PLC, 8,199,199 ordinary shares in cirqual PLC and all dividends interest and other moneys paid or payable on the said shares. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent security deposit deed | Creato il 21 gen 1988 Consegnato il 09 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 50000 under a lease dateed 21/1/88 | |
Brevi particolari Sterling pounds 50000 together with any interest earned thereon by reason of depositing the sum of sterling pounds 50000 in a joint deposit account with barclays bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GARTLAND WHALLEY AND BARKER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0